GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01985860 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road SK1 3SW Stockport United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OCEANTOWN LIMITED | 04. Feb. 1986 | 04. Feb. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Mai 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Mai 2022
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Mai 2021 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Mai 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Karen Rosaleen Robbins als Direktor am 31. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Bruce Dingwall als Direktor am 31. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Colin Brown als Geschäftsführer am 31. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Stagecoach Services Ltd Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU zum C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW am 16. Nov. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUX, Michael John | Sekretär | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | British | 137383880001 | ||||||
| DINGWALL, Bruce Maxwell | Geschäftsführer | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 185252790001 | |||||
| ROBBINS, Karen Rosaleen | Geschäftsführer | Chendre Close Hayfield SK22 2PH High Peak 8 Derbyshire England | England | British | 73518280001 | |||||
| CLAYTON, Michael Bruce | Sekretär | Lark Rise Longrose Lane Kniveton DE6 1JL Ashbourne Derbyshire | British | 27890500005 | ||||||
| FULLER, Alan Charles | Sekretär | Freshwater Cottage 2 Chapel Brow Charlesworth SK13 5HH Glossop Derbyshire | British | 70283550001 | ||||||
| HOUSTON, Guy Alan | Sekretär | 5 Bar Croft Newbold S40 4YG Chesterfield Derbyshire | British | 54321810002 | ||||||
| REAY, David | Sekretär | 49 The Grange Tanfield Lea DH9 9UT Stanley Durham | British | 57307420001 | ||||||
| WHITNALL, Alan Leonard | Sekretär | 25 Millhill Drive Greenloaning FK15 0LS Dunblane Perthshire | British | 54184420002 | ||||||
| WHITNALL, Alan Leonard | Sekretär | 25 Millhill Drive Greenloaning FK15 0LS Dunblane Perthshire | British | 54184420002 | ||||||
| YATES, Brian John | Sekretär | 11 Caenby Road DN35 0JT Cleethorpes South Humberside | British | 3332040001 | ||||||
| BRITTEN, Michael | Geschäftsführer | 29 Bath Road Bracebridge Heath LN4 2TU Lincoln Lincolnshire | British | 68579580002 | ||||||
| BROWN, Colin | Geschäftsführer | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 85970020003 | |||||
| CARTWRIGHT, Kenneth James | Geschäftsführer | 490 Leads Road Sutton HU7 4XS Hull East Yorkshire | British | 53774110001 | ||||||
| CLAYTON, Michael Bruce | Geschäftsführer | Lark Rise Longrose Lane Kniveton DE6 1JL Ashbourne Derbyshire | British | 27890500005 | ||||||
| COCHRANE, Keith Robertson | Geschäftsführer | Glen Hall Belwood Park PH2 7AJ Perth | British | 47574960002 | ||||||
| COCHRANE, Keith Robertson | Geschäftsführer | 23g Victoria Circus G12 9LB Glasgow Strathclyde | British | 47574960001 | ||||||
| COWOOD, Alan | Geschäftsführer | 38 Grimsby Road DN35 7AB Cleethorpes South Humberside | British | 42106750001 | ||||||
| CURRIE, David Andrew | Geschäftsführer | 260 Welholme Road DN32 9JB Grimsby South Humberside | British | 21532110001 | ||||||
| DIXON, Christine Florence Werton | Geschäftsführer | 149 Lord Street DN31 2NH Grimsby South Humberside | British | 35178250001 | ||||||
| FULLER, Alan Charles | Geschäftsführer | Freshwater Cottage 2 Chapel Brow Charlesworth SK13 5HH Glossop Derbyshire | England | British | 70283550001 | |||||
| GLOAG, Ann Heron | Geschäftsführer | Kinfauns Castle PH2 7JZ Perth Perthshire | Scotland | British | 141120003 | |||||
| GRIFFITHS, Martin Andrew | Geschäftsführer | Upland 2 Dupplin Terrace PH2 7DG Perth | Scotland | British | 61722690002 | |||||
| HINKLEY, William Barry | Geschäftsführer | Mandalay Bassenthwaite CA12 4QG Keswick Cumbria | England | British | 2268190002 | |||||
| HOUSTON, Guy Alan | Geschäftsführer | 5 Bar Croft Newbold S40 4YG Chesterfield Derbyshire | British | 54321810002 | ||||||
| HOWITT, Malcolm | Geschäftsführer | 36 Castlereagh Wynyard Park TS22 5QF Billingham | British | 14928120002 | ||||||
| HUNSLEY, Charles, Councillor Mr | Geschäftsführer | 104 Station Road Stallingborough DN37 8AP Grimsby South Humberside | British | 32535140001 | ||||||
| KAY, Richard Shaw | Geschäftsführer | 7 Alderson Road S80 1UZ Worksop Nottinghamshire | British | 62121140001 | ||||||
| KINSKI, Michael John | Geschäftsführer | Cherry Tree House 268 Dunchurch Road CV22 6HX Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 58643710001 | |||||
| KIRSOPP, David | Geschäftsführer | 36 Thorganby Road DN35 0HP Cleethorpes South Humberside | British | 46192950001 | ||||||
| LILES, Malcolm David, The Reverend | Geschäftsführer | The Rectory 1 Southgate Road RH10 6BL Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 118651910001 | |||||
| LYNCH, Paul Graham | Geschäftsführer | 3 Ordoyno Grove Coddington NG24 2RY Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | 68577470002 | |||||
| MILLS, Peter Mc Michael | Geschäftsführer | Ravendale House East Ravendale DN37 0RX Grimsby South Humberside | British | 3332090001 | ||||||
| NOLAN, Gary James | Geschäftsführer | 65 Newman Road S60 3JB Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 65317320001 | |||||
| POPE, John | Geschäftsführer | 6 Newark Road Wellow NG22 0EH Newark Nottinghamshire | British | 18268990001 | ||||||
| PYBIS, Barry Dennis | Geschäftsführer | 30 Sandstone Avenue Walton S42 7NS Chesterfield Derbyshire | British | 92801970001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagecoach Bus Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GRIMSBY-CLEETHORPES TRANSPORT COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Erstellt am 30. Sept. 1996 Geliefert am 12. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under the agreement and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without prejudice to the foregoing generality, all obligations to indemnify the chargee (the "secured liabilities") provided that the expression secured liabilites shall not include any relevant liabilities of the company | |
Kurze Angaben (1) as security for the payment of all secured liabilities, the chargor with full title guarantee charges in favour of the chargee for itself and as agent and security trustee aforesaid by way of floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 02. Feb. 1996 Geliefert am 17. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto | |
Kurze Angaben By way of floating charge all its undertaking property assets and rights present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Nov. 1993 Geliefert am 03. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pusuant to a guarantee dated 25TH november 1993 | |
Kurze Angaben F/H premises k/a bus depot vicoria street grimsby. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Nov. 1993 Geliefert am 03. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Okt. 1986 Geliefert am 18. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000 2ND all other moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Okt. 1986 Geliefert am 18. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000 2ND all other moneys due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0