DS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01985914 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DS LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich DS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Witan Gate House 500-600 Witan Gate West MK9 1SH Milton Keynes Buckinghamshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AXIELL LIMITED | 05. Dez. 2008 | 05. Dez. 2008 |
DS RENTALS LIMITED | 19. Feb. 1993 | 19. Feb. 1993 |
D.S. INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 05. Feb. 1986 | 05. Feb. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DS LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für DS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Fraser als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jerk Sintorn als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mats Anders Tomas Hentzel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew George Fraser als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Jerry Joel Sommerfeldt als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Pegg als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nigel Arthur Pegg am 10. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nigel Arthur Pegg am 09. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Shoosmiths Secretaries Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOOSMITHS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 500-600 Witan Gate West MK9 1SH Milton Keynes Witan Gate House Buckinghamshire United Kingdom |
| 76282680012 | ||||||||||
HENTZEL, Mats Anders Tomas | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate West MK9 1SH Milton Keynes Witan Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Sweden | Swedish | Company Director | 129520140001 | ||||||||
SOMMERFELDT, Jerry Joel | Geschäftsführer | 224 68 Lund Barytongranden 20 Sweden | Sweden | Swedish | President & Ceo | 176189640001 | ||||||||
CROCKER, Paul Stewart | Sekretär | Cherry Orchard 1 Hollow Road Breedon On The Hill DE73 1AU Derby Derbyshire | British | 12633220001 | ||||||||||
LOUKES, Kenneth Martin | Sekretär | 52 Forge End AL2 3EQ St Albans Hertfordshire | British | 6945830002 | ||||||||||
ROSEFIELD, Stephen Michael, Dr | Sekretär | 53 Lanchester Road N6 4SX London | British | 51560380001 | ||||||||||
SMALLWOOD, Roger John | Sekretär | Hall View Drive Bilborough NG8 4GD Nottingham Unit 2 England | British | 60826380001 | ||||||||||
BIZLEY, John Geoffrey | Geschäftsführer | Cinderford Hellingley BN27 4HL Hailsham East Sussex | British | Chartered Accountant | 35551880001 | |||||||||
FRASER, Andrew George | Geschäftsführer | Off Glaisdale Drive West Bilborough NG8 4GD Nottingham Hall View Drive United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 176189630001 | ||||||||
LOUKES, Kenneth Martin | Geschäftsführer | 52 Forge End AL2 3EQ St Albans Hertfordshire | England | British | Director | 6945830002 | ||||||||
PEGG, Nigel Arthur, Mr. | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate West MK9 1SH Milton Keynes Witan Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Computer Consultant | 3173910001 | ||||||||
ROSEFIELD, John Stuart Ian | Geschäftsführer | 3 Keats Grove Hampstead NW3 2RT London | United Kingdom | British | Company Director | 8320370001 | ||||||||
SINTORN, Jerk Olof | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate West MK9 1SH Milton Keynes Witan Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Sweden | Swedish | Company Director | 130277460001 | ||||||||
SMALLWOOD, Roger John | Geschäftsführer | Hall View Drive Bilborough NG8 4GD Nottingham Unit 2 England | England | British | Finance Director | 60826380001 | ||||||||
TICKLE, John Henry | Geschäftsführer | Park Lane Sutton Bonington LE12 5NQ Loughborough 77 Leicestershire | British | Commercial Director | 17567820002 |
Hat DS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Assignment and charge of sub-leasing agreements | Erstellt am 22. Feb. 1999 Geliefert am 23. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All the rights title and interest of the company in lease contract no 1006/01 dated 04/11/98 and made pursuant to a master agreement number 1006 for further details please refer to form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Juli 1997 Geliefert am 30. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment and charge of sub-leasing agreements | Erstellt am 06. Feb. 1997 Geliefert am 12. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights title and interest in a lease contract no. 1005/01 dated 17 janauary 1997 made pursuant to a master agreement no 1005 dated 1 november 1996 between the company, d s limited and bedfordshire county council in respect of new computor systems comprised in hire purchase agreements between barclays mercantile business finance and the company with the benefit of all guarantees and indemnities in connection therewith. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment and charge of sub-leasing agreements | Erstellt am 30. Apr. 1996 Geliefert am 02. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the specified sub-agreement and/or this deed | |
Kurze Angaben All the rights title and interest of the company in lease contracts no.1001/02 Dated 11TH december 1993 and 1001/03 dated 1ST january 1996. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment and charge of sub-leasing agreements | Erstellt am 18. Dez. 1995 Geliefert am 21. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the rights title and interest of the company in the lease contract no 1003/01 dated 1/10/95 and made pursuant to a master agreement no. 1003 dated 23/1/95 in respect of a new computerised library system. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of sub-leasing agreement | Erstellt am 21. Juli 1995 Geliefert am 25. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All the rights, title and interest of the company in lease contract no.1004/01 Dated 1ST may 1995. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment & charge of sub-leasing agreements | Erstellt am 30. März 1993 Geliefert am 08. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights title and interest of the company in sub-leases in respect of equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0