01987358 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname01987358 LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01987358
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 01987358 LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich 01987358 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Regent House
    Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 01987358 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    JORDANS 333 PUBLIC LIMITED COMPANY07. Feb. 198607. Feb. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 01987358 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am05. Apr. 2005
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am05. Feb. 2006
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2004

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für 01987358 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis08. Aug. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung22. Aug. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für 01987358 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für 01987358 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in Gläubigerinsolvenz

    4 SeitenREST-CVL

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed anglo united\certificate issued on 08/10/18
    SeitenCERTNM

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    25 SeitenLIQ14

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    18 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Feb. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Feb. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Feb. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Feb. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Feb. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2012

    5 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    34 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Feb. 2012

    5 Seiten4.68

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    28 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2011

    5 Seiten4.68

    Wer sind die Geschäftsführer von 01987358 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VEERMAN, Robert Arnold
    Pentaren
    Mansfield Road Heath
    S44 5SE Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    Pentaren
    Mansfield Road Heath
    S44 5SE Chesterfield
    Derbyshire
    Dutch144829040001
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish16220320001
    MUIRHEAD, Hugh Spencer
    Hill Top Farm Heathcote
    SK17 0AY Hartington
    Derbyshire
    Sekretär
    Hill Top Farm Heathcote
    SK17 0AY Hartington
    Derbyshire
    British49836570001
    VEASEY, John Robert
    57 Busheywood Road
    Dore
    S17 3QA Sheffield
    Sekretär
    57 Busheywood Road
    Dore
    S17 3QA Sheffield
    British1134670001
    WALLACE, George Roger
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    British139570001
    BELL, Denis
    1 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Geschäftsführer
    1 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    British3885760003
    BROOKS, Alan
    The Chantry
    Little Casterton
    PE9 4BE Stamford
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Chantry
    Little Casterton
    PE9 4BE Stamford
    Lincolnshire
    British13032530001
    COTTAM, Harold, Managing Director
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    Geschäftsführer
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    United KingdomBritish32116700002
    GAINHAM, John Henry
    32 Drayton Gardens
    SW10 9SA London
    Geschäftsführer
    32 Drayton Gardens
    SW10 9SA London
    British565790004
    MCERLAIN, David Patrick
    Longstone Hall
    Great Longstone
    DE45 1TZ Bakewell
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Longstone Hall
    Great Longstone
    DE45 1TZ Bakewell
    Derbyshire
    British780940004
    NASH, John Alfred Stoddard
    The Old Rectory
    Ewelme
    OX10 6HP Wallingford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Ewelme
    OX10 6HP Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish3930780001
    STANTON, Howard Terence
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish52013920003
    WALLACE, George Roger
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    British139570001

    Hat 01987358 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignment of benefit of a deposit agreement
    Erstellt am 16. Sept. 2004
    Geliefert am 21. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the benefit of the company's interest in any sums payable to the company under a deposit agreement including the payment to the company of any part of the deposit at the expiry of the deposit agreement (the "reversion") together with all rights and interests of the company present and future arising out of or in connection with or relating to the reversion.
    Berechtigte Personen
    • Ever 1813 Limited
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture
    Erstellt am 22. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex. Lawrie Factors
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 20. Nov. 2002
    Geliefert am 26. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex Lawrie Factors
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 30. Okt. 2002
    Geliefert am 02. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated business investment account and numbered 07498193 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental charge
    Erstellt am 15. Feb. 1993
    Geliefert am 02. März 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the trustee, the agent or the lenders (each as defined therein) under various documents referred to therein
    Kurze Angaben
    The supplemental charge is supplemental to the charge and, on and with effect from 12TH march 1993 provided the conditions referred to in clause 3 of the supplemental charge have then been satisfied or waived, amends various definitions in the charge and amends, supplements and deletes various other provisions of the charge.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co. LTD
    Transaktionen
    • 02. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 15. Feb. 1993
    Geliefert am 26. Feb. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the trustee, the agent or the lenders (each as defined therein) under each of the loan documents (as defined therein) to which the company is party, the debenture and any guarantee (each as defined therein)
    Kurze Angaben
    The proceeds of sale of the real property together with all the other property as detailed in the short particulars detailed on form M395 (see form M395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co. Ltdfinedin Its Capacity as Trustee for the Lenders as De
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Deed of debenture (as supplemented by a supplemental deed of debenture dated 4 march 1993)
    Erstellt am 23. Feb. 1990
    Erworben am 26. Sept. 2000
    Geliefert am 03. Okt. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or owing by the company to the chargee the agent or the lenders under the guarantee the debenture and any other loan documents
    Kurze Angaben
    All stock shares debentures loan capital rights to subscribe for convert other securities into or otherwise acquire any stocks shares debentures and loan capital of any other body corporate now or at any time hereafter belonging to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu and Co Limited as Trustee for the Lenders
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Deposit charge
    Erstellt am 05. Feb. 1990
    Geliefert am 21. Feb. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a rate agreement dated 22/11/89
    Kurze Angaben
    All the company's interest in and all sums standing to the credit of such account wherein the sum of £980,000 has been deposited or may be deposited for the purpose of this charge.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1989
    Geliefert am 24. Aug. 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the lenders and the agent) as defined in the deed under the terms of the loan documents to which the company is party and/or this debenture and/or (as the case may be) any guarantee in existance at the time of such demand
    Kurze Angaben
    See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Jan. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Guarantee facility deposit agreement
    Erstellt am 06. Juli 1989
    Geliefert am 19. Juli 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the hongkong and shanghai banking corporation under the terms of the clause 6.1 of the guarantee facility agreement dated 23.5.89 (the hsbc obligations as defined in the deed) and all monies due or to become due from the company to samuel montagu & co. Limited under terms of the clause 6.1 of the guarantee facility agreement dated 23.5.89 (the sm obligations as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of the account with samuel montagu & co limited entitled "call deposit account re derby-others "no. 0852308 and all monies standing to the credit of the account with the hongkong and shanghai banking corporation entitled "hsbc re derby PLC" no. 09440 78524.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu and Co Limited
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
    Transaktionen
    • 19. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    Guarantee facility deposit agreement
    Erstellt am 23. Mai 1989
    Geliefert am 05. Juni 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to hongkong and shanghai banking corporation under or pursuant to clause 6.1 of the guarantee facility agreement of even date (the hongkong and shanghai banking corporation obligations as defined in the deed) & all moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited under or pursuant to clause 6.1 of the guarantee facility agreement of even date ( the samuel montagu & co limited obligations as defined in the deed) under the terms of the guarantee facility agreement
    Kurze Angaben
    All monies deposited during the subsistence of the security constituted by the guarantee facility deposit agreement standing to the credit of the account entitiled "call deposit account re:derby -others " no. 0852308 (for full details see 395).
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    • The Hongkong and Shanghai Banking Coporation
    Transaktionen
    • 05. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    Share purchase revolving credit facility letter
    Erstellt am 23. Mai 1989
    Geliefert am 05. Juni 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the hongkong and shanghai banking corporation under the terms or the charge
    Kurze Angaben
    All the right title & interest of the company standing to the credit of the cash collateral account designated " derby share security account".
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 23. Mai 1989
    Geliefert am 05. Juni 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the lenders (as defined in the deed) and as agent for itself & the hongkong & shanghai banking corporation & any bank which is an acceeding bank from time to time in accordance with the terms of the charge under the terms of the facility agreements this charge or any of the loan documents (all as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    Any shares in the capital of nsm PLC & all dividends, interest or other monies paid thereon.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 23. Mai 1989
    Geliefert am 05. Juni 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the lenders (as defined in the deed) and as agent for itself & the hongkong & shanghai banking corporation & any bank which is an acceeding bank from time to time in accordance with the terms of the charge under the terms of the facility agreements this charge or any of the loan documents (all as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    Any shares in the capital of coalite group PLC & all dividends, interest or other monies paid thereon.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 1989Registrierung einer Belastung

    Hat 01987358 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Feb. 2018Aufgelöst am
    13. Feb. 2006Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Praktiker
    Pkf
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Ian James Gould
    Pkf (Uk) Llp
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Praktiker
    Pkf (Uk) Llp
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Francis Graham Newton
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Brian James Hamblin
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praktiker
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praktiker
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0