MARSHALL ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MARSHALL ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01995655 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MARSHALL ESTATES LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich MARSHALL ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 137 Scalby Road YO12 6TB Scarborough North Yorkshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MARSHALL ESTATES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MARSHALL DEVELOPMENTS LIMITED | 25. Juni 1986 | 25. Juni 1986 |
| SCOPEIDEAL LIMITED | 05. März 1986 | 05. März 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARSHALL ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MARSHALL ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 23 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 91 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 43 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 24 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 163 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 164 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 60 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 118 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 132 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 162 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 125 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 151 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 83 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. März 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MARSHALL ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIERS, Barry Peter | Sekretär | Scalby Road YO12 6TB Scarborough 137 North Yorkshire England | British | 36788700002 | ||||||
| GUTHRIE, John | Geschäftsführer | Scalby Road YO12 6TB Scarborough 137 North Yorkshire England | England | British | 946780001 | |||||
| KIRKHAM, David John | Geschäftsführer | Ephesus Roshven, Glenuig PH38 4NB Lochailort Inverness-Shire | United Kingdom | British | 1582960004 | |||||
| ROBSON, Martin | Geschäftsführer | Scalby Road YO12 6TB Scarborough 137 North Yorkshire England | United Kingdom | British | 80183630002 | |||||
| SWIERS, Barry Peter | Geschäftsführer | Scalby Road YO12 6TB Scarborough 137 North Yorkshire England | England | British | 36788700002 | |||||
| JOHNSON, James Martin | Sekretär | Farmleigh Scalby YO13 0RP Scarborough | British | 583090001 | ||||||
| MARSHALL, Patricia | Sekretär | Spikers Hill Cottage West Ayton YO13 9LB Scarborough North Yorkshire | British | 1598740001 | ||||||
| BALL, Kenneth Francis | Geschäftsführer | Moor View Silpho YO13 0JP Scarborough North Yorkshire | British | 1260370002 | ||||||
| BENTLEY, Nicholas John | Geschäftsführer | 11 Throxewby Lane Newby YO13 5HN Scarborough North Yorkshire | British | 63672440001 | ||||||
| JOHNSON, James Martin | Geschäftsführer | Farmleigh Scalby YO13 0RP Scarborough | United Kingdom | British | 583090001 | |||||
| MARSHALL, Michael Peter Herbert | Geschäftsführer | Spikers Hill Farm West Ayton YO13 9LB Scarborough North Yorkshire | British | 1598760001 | ||||||
| MARSHALL, Patricia | Geschäftsführer | Spikers Hill Cottage West Ayton YO13 9LB Scarborough North Yorkshire | England | British | 1598740001 | |||||
| MARSHALL, Timothy Stuart | Geschäftsführer | 28 Morley Drive West Ayton YO13 9LF Scarborough North Yorkshire | British | 1598770001 | ||||||
| SHEPPARD, Ian | Geschäftsführer | 22 Kingsway Newby YO12 6SG Scarborough North Yorkshire | British | 36070480001 | ||||||
| SWIERS, Barry Peter | Geschäftsführer | 17 Gillylees Stepney YO12 5DR Scarborough North Yorkshire | British | 36788700001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MARSHALL ESTATES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadland Properties Limited | 06. Apr. 2016 | Scalby Road YO12 6TB Scarborough 137 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MARSHALL ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Erstellt am 16. März 2007 Geliefert am 17. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £38,400.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben 9 shire fold eastfield scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 09. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property k/a 72 harvest way, eastfield, scarborough, north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Juli 2006 Geliefert am 19. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 6 shire fold eastfield scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 05. Dez. 1997 Geliefert am 10. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or simon mark walters and kay cowdery to the chargee under the terms of the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 10 sheldrake close filey north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 03. Okt. 1997 Geliefert am 15. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other parties named therein under the terms of the nationwide mortgage conditions 1991 | |
Kurze Angaben 9 sheldrake close filey north yorkshire YO14 obl. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Juli 1997 Geliefert am 29. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or colin robert hinchliffe under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 8 mallard close the pastures filey north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Juni 1997 Geliefert am 11. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 4 mallard close filey north yorkshire floating charge over all moveable plant machinery implements of all kings utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. Mai 1997 Geliefert am 03. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or joseph agustus and sandra agustus to the chargee under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 5 mallard close filey north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. März 1997 Geliefert am 22. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or john sellers and karen elizabeth eyles under the terms of the deed | |
Kurze Angaben 1 mallard close pasture crescent filey north yorkshire YO14 0BN. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 21. Jan. 1997 Geliefert am 31. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or nicholas kintos and deborah eade kontos under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 4 shire close eastfield scarborough north yorkshire YO11 3YZ. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. Jan. 1997 Geliefert am 31. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due form the company and/or peter philip wallis under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 14 pasture cresecent north yorkshire Y014 obp. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. Dez. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or dawn grace sunter to the chargee under the terms of the mortgage | |
Kurze Angaben The land and property situate and k/a 4 shire croft eastfield scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 29. Jan. 1996 Geliefert am 02. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or betty radford-davis to the chargee under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 8 sheldrake close filey north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 29. Sept. 1995 Geliefert am 02. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or robert anthony hudson and nichola anne hudson to the chargee under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 1 sheldrake close, filey, north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 25. Aug. 1995 Geliefert am 31. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or karl brian wilson and bridget wilson to the chargee under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 50 harvest way, eastfield, scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. Juli 1995 Geliefert am 02. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or wayne lee andrews and gaye suzanne pollard to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben 9 shire close eastfield scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Juni 1995 Geliefert am 21. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or james john worrall and melissa jayne worrall under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben Number 12 (formerly plot 24) shedldrake close filey north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. März 1995 Geliefert am 23. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or steven richard brewster and claire louise brewster under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 1 shire fild eastfield scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Feb. 1995 Geliefert am 24. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or frank wilson and tracy redfearn under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 12 shire fold eastfield scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1994 Geliefert am 12. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or scott saunders to the chargee under the terms of the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 17 shire croft eastfield scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Nov. 1994 Geliefert am 14. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or jennifer coreen cammish to the chargee under the terms of the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 8 pasture crescent filey north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. Jan. 1994 Geliefert am 11. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or colin james jenkinson and susan jayne jenkins to the chargee under the terms of the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 5 mallard close filey north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Jan. 1994 Geliefert am 11. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or david coates and lesley johnson to the chargee under the terms of the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 16 shire close harvest way scarborough YO11 3YZ. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1993 Geliefert am 07. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or lance william james and paula judith james under the terms of the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 3 ( formerly plot 56 ) cygnet close the pastures filey north yorkshire YO14 0XX. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Sept. 1993 Geliefert am 30. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or david john birkinand catherine lynn birkin under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben Number 8, (formerly plot 51) cygnet close, filey, north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0