BRIGHTSEA EN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRIGHTSEA EN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01996143
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRIGHTSEA EN LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EVANS NORTHERN LIMITED12. Apr. 199112. Apr. 1991
    COUNTY PROPERTIES (SUNDERLAND) LIMITED17. Juli 198617. Juli 1986
    MARCHLARK LIMITED05. März 198605. März 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 03. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2011

    6 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2010

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    15 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    15 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Section 175(5)(a) quoted 10/11/2008
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Sekretär
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Sekretär
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Sekretär
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Geschäftsführer
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Geschäftsführer
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat BRIGHTSEA EN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 19. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Juni 2005
    Geliefert am 18. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land and buildings on the east side of mill lane, winwick quay, warrington t/nos. CH211305 and CH211306 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 01. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH spetember 1995 and deeds (all as defined in the deed of release and substitution and defined on the form 395) all of which are supplemental to the trust deed dated 20TH september 1985
    Kurze Angaben
    Land at the east side of mill lane warrington cheshire t/nos CH211305 and CH211306 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Erstellt am 03. Aug. 1999
    Geliefert am 16. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental trust deed
    Erstellt am 04. Dez. 1992
    Geliefert am 08. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all othedr monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Signal house waterloo place sunderland tyne and wear. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. März 1988
    Geliefert am 14. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land between waterloop place and holmside sunderland tyne and wear title no TY200642 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 25. März 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 16. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 23. Jan. 1987
    Geliefert am 29. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All benefit of the building agreement dated 19/9/86.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0