DERBY OMNIBUS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DERBY OMNIBUS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01998602 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DERBY OMNIBUS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DERBY OMNIBUS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DERBY OMNIBUS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DARTPINE LIMITED | 15. Sept. 1989 | 15. Sept. 1989 |
| DERBY CITY TRANSPORT LIMITED | 11. März 1986 | 11. März 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DERBY OMNIBUS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DERBY OMNIBUS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Turner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Paul Turner am 30. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 30. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 30. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DERBY OMNIBUS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne And Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Geschäftsführer | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village | England | British | 161250030001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Sekretär | 4 Waterfield Road Cropston LE7 7HN Leicester | British | 35116070001 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Sekretär | 4 Waterfield Road Cropston LE7 7HN Leicester | British | 35116070001 | ||||||
| JARRATT, Andrew Howard | Sekretär | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | British | 1860730001 | ||||||
| THORPE, Elizabeth Anne | Sekretär | 2 Oakwood DH7 0NP Lanchester County Durham | British | 102907000001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| VIRTUE, John | Sekretär | 91 Hollywood Avenue Gosforth NE3 5BU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 102404840001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Sekretär | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BAYFIELD, Stephen | Geschäftsführer | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BICKLE, Kenneth | Geschäftsführer | Langton Cottage Roston DE6 2EH Ashbourne Derbyshire | British | 3036960002 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| CUMMING, Graham Jackson | Geschäftsführer | Tudor House 19 Ashpole Furlong Loughton MK5 8EA Milton Keynes | British | 22410440002 | ||||||
| HIND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 173 Station Road Cropston LE7 7HH Leicester Leicestershire | British | 21961900001 | ||||||
| JARRATT, Andrew Howard | Geschäftsführer | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 1860730001 | |||||
| JONES, Michael Adrian | Geschäftsführer | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 48937720001 | |||||
| WATT, Gordon George | Geschäftsführer | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | 67622780002 | |||||
| WILLIAMS, Dawson Thomas | Geschäftsführer | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | 2719600006 |
Hat DERBY OMNIBUS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 15. Juni 1995 Geliefert am 20. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 25. Aug. 1989 Geliefert am 14. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. März 1988 Geliefert am 08. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings at ascot drive london road derby. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DERBY OMNIBUS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0