CAMTRO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CAMTRO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02003533 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAMTRO LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CAMTRO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CAMTRO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SELF-CHANGING GEARS LIMITED | 10. Juni 1986 | 10. Juni 1986 |
| EAGERCRAFT LIMITED | 25. März 1986 | 25. März 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMTRO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CAMTRO LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CAMTRO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Warwick House PO Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU zum 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Juli 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ann Louise Holding am 03. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAMTRO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKES, David Stanley | Sekretär | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | British | 25179240002 | ||||||
| HOLDING, Ann-Louise | Geschäftsführer | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 73464490003 | |||||
| PARKES, David Stanley | Geschäftsführer | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 25179240002 | |||||
| DICKINSON, George Kenneth | Sekretär | 95 Windy Arbour CV8 2BJ Kenilworth Warwickshire | British | 17280390001 | ||||||
| EARDLEY, Barry Eric | Sekretär | The Cedars Tamworth Road CV7 8JJ Keresley Coventry | British | 36645710001 | ||||||
| GOULDING, Jacqueline Elizabeth | Sekretär | 3 Sidmouth Close CV11 6FA Nuneaton Warwickshire | British | 49027500001 | ||||||
| JARMAN, Patrick Edmund | Sekretär | 68 Replingham Road SW18 5LW London | British | 66608960002 | ||||||
| LANGLEY, Paul Michael | Sekretär | 47 Redbourn Road WS3 3XT Bloxwich West Midlands | British | 47929580002 | ||||||
| DICKINSON, George Kenneth | Geschäftsführer | 95 Windy Arbour CV8 2BJ Kenilworth Warwickshire | British | 17280390001 | ||||||
| EARDLEY, Barry Eric | Geschäftsführer | The Cedars Tamworth Road CV7 8JJ Keresley Coventry | British | 36645710001 | ||||||
| GREENSLADE, Martin Frederick | Geschäftsführer | 2 The Glade TN13 3HD Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 17633990002 | |||||
| HOYLE, David John | Geschäftsführer | 10 Berwick Close Woodloes Park CV34 5UF Warwick Warwickshire | British | 17280400001 | ||||||
| JARMAN, Patrick Edmund | Geschäftsführer | 68 Replingham Road SW18 5LW London | British | 66608960002 | ||||||
| MITCHELL, Stuart Roger | Geschäftsführer | Little Trees Queens Hill Rise SL5 7DP Ascot Berkshire | New Zealand | 1447530001 | ||||||
| PEARSON, Anthony Ralph | Geschäftsführer | 15 Oakfields Road SG3 6NS Knebworth Hertfordshire | British | 8659000001 | ||||||
| ROWE, Christopher Gordon | Geschäftsführer | Bluebell Grange Allscott TF6 5EB Telford Salop | British | 113894430001 | ||||||
| WEBSTER, Donald James | Geschäftsführer | 58 Longrood Road Bilton CV22 7RE Rugby Warwickshire | British | 37379940001 | ||||||
| WINCH, Brian Clappison | Geschäftsführer | The Old Rectory Knapton Green, Knapton NR28 0RU North Walsham Norfolk | England | British | 64371830001 |
Hat CAMTRO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998 | Erstellt am 15. Mai 2003 Geliefert am 21. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998 | Erstellt am 15. Mai 2003 Geliefert am 21. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Floating charge over all undertaking property assets and revenues. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and charge of registered designs and design right | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and charge of copyright and design rights | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of trade marks, trade names and goodwill | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and charge of patents | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben All inventions and patents specified in form 395 together with all inventions and patents belonging to the mortgagor present and future at the date of the charge. Patent no's: 5031477. 0 420 446 (e) (X2). 2172 672. 2235663. P690 01 168.7 14889/1990. 5 031 477.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined) | Erstellt am 12. Juli 1994 Geliefert am 22. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined) | Erstellt am 12. Juli 1994 Geliefert am 22. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge. | Erstellt am 30. Sept. 1991 Geliefert am 15. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this deed. | |
Kurze Angaben (See doc M395-ref M816 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 11. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trade marks mortgage | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 11. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All trade marks and applications for trade marks as defined on form M395 reg M137. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Patents charge | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 11. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All inventions and patents as defined on form M395 reg M127. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Designs charge | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 11. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All designs as defined on form M395, reg M117. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of copyright | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 11. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All copyrights, design rights and rights defined on form M395, reg M107. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CAMTRO LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0