CAMTRO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAMTRO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02003533
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAMTRO LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich CAMTRO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CAMTRO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SELF-CHANGING GEARS LIMITED10. Juni 198610. Juni 1986
    EAGERCRAFT LIMITED25. März 198625. März 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMTRO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CAMTRO LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAMTRO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Warwick House PO Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU zum 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Juli 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Juni 2015

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 17. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 4,643,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 4,643,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ann Louise Holding am 03. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CAMTRO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Sekretär
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    British25179240002
    HOLDING, Ann-Louise
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish73464490003
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish25179240002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    Sekretär
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Sekretär
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GOULDING, Jacqueline Elizabeth
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    Sekretär
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    British49027500001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Sekretär
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    LANGLEY, Paul Michael
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    Sekretär
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    British47929580002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Geschäftsführer
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GREENSLADE, Martin Frederick
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish17633990002
    HOYLE, David John
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    British17280400001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Geschäftsführer
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    MITCHELL, Stuart Roger
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    New Zealand1447530001
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    British8659000001
    ROWE, Christopher Gordon
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    British113894430001
    WEBSTER, Donald James
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    British37379940001
    WINCH, Brian Clappison
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    EnglandBritish64371830001

    Hat CAMTRO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    Erstellt am 15. Mai 2003
    Geliefert am 21. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    Erstellt am 15. Mai 2003
    Geliefert am 21. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Floating charge over all undertaking property assets and revenues.
    Berechtigte Personen
    • Alvis PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of registered designs and design right
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of copyright and design rights
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of trade marks, trade names and goodwill
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of patents
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    All inventions and patents specified in form 395 together with all inventions and patents belonging to the mortgagor present and future at the date of the charge. Patent no's: 5031477. 0 420 446 (e) (X2). 2172 672. 2235663. P690 01 168.7 14889/1990. 5 031 477.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    Erstellt am 12. Juli 1994
    Geliefert am 22. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Each of the Banks
    Transaktionen
    • 22. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    Erstellt am 12. Juli 1994
    Geliefert am 22. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Each of the Banks
    Transaktionen
    • 22. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and supplemental charge.
    Erstellt am 30. Sept. 1991
    Geliefert am 15. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this deed.
    Kurze Angaben
    (See doc M395-ref M816 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 25. Juni 1990
    Geliefert am 11. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trade marks mortgage
    Erstellt am 25. Juni 1990
    Geliefert am 11. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All trade marks and applications for trade marks as defined on form M395 reg M137.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Patents charge
    Erstellt am 25. Juni 1990
    Geliefert am 11. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All inventions and patents as defined on form M395 reg M127.
    Berechtigte Personen
    • Barclayds Bank Plcd in the Deed)(For Itself and as Agent for the Banks as Define
    Transaktionen
    • 11. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Designs charge
    Erstellt am 25. Juni 1990
    Geliefert am 11. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All designs as defined on form M395, reg M117.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of copyright
    Erstellt am 25. Juni 1990
    Geliefert am 11. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All copyrights, design rights and rights defined on form M395, reg M107.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CAMTRO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. März 2016Aufgelöst am
    16. Juni 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0