GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02006409
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    • (5530) /

    Wo befindet sich GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GROUPE CHEZ GERARD LIMITED09. Sept. 199109. Sept. 1991
    LAKEBIRD LEISURE LIMITED13. Juni 198613. Juni 1986
    LAKEBIND LIMITED03. Apr. 198603. Apr. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Jan. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    GAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    32 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Okt. 2013

    26 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Okt. 2012

    35 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Mai 2012

    39 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    61 Seiten2.17B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    61 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    15 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH* am 05. Dez. 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Provision of articles hereby revoked 29/09/2011
    RES13
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 29. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 15,992,000
    4 SeitenSH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 29. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 492,000.0
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Jan. 2011

    20 SeitenAA

    legacy

    10 SeitenMG01

    Ernennung von Mr Stephen Rushworth Smith als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 29. Juni 2010 bis 29. Dez. 2010

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Mr William Rollason als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Simon George Rowe als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Phillips als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Hill als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROWE, Simon George
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    Geschäftsführer
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    EnglandBritish68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Geschäftsführer
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritish6894950002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Sekretär
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    British148079910001
    GAMBLE, Stephen
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    Sekretär
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    British106836430001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Sekretär
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Sekretär
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    British130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Sekretär
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Sekretär
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    British2996380001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Sekretär
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    ABRAHAM, Neville Victor
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    Geschäftsführer
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    British10579160003
    ABRAHAM, Neville Victor
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    Geschäftsführer
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    United KingdomBritish10579160002
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Geschäftsführer
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritish140766360001
    BERTORELLI, Adrian Peter
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    British15898860001
    BINDER, Simon
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    Geschäftsführer
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    United KingdomBritish97451910001
    BROWN, Christopher Niall Bridgmore
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    EnglandBritish99369900001
    DA COSTA, Michael Phillip
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    Geschäftsführer
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    British26140900002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Geschäftsführer
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish148079910001
    EDWARDS, Terence David
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    British15898850001
    ENGLISH, Tina
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    Geschäftsführer
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    British98725570001
    FARROW, Edmund John
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    Geschäftsführer
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    British51885010001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HAND, Alan
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Irish102272320001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Geschäftsführer
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritish130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Geschäftsführer
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Geschäftsführer
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    United KingdomBritish2996380001
    JELFFS-SHUCKBURGH, Deborah Ann
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    British77499800001
    LEDERER, John David
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    Geschäftsführer
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    United KingdomBritish86140390001
    MCKAY, Nicholas Adrian Richard
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    Geschäftsführer
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    British14633330001
    MILNER, Pauline Alice
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    Geschäftsführer
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    United KingdomBritish51885090002
    MIRRELSON, Joseph Bernard
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    Geschäftsführer
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    British40430150001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Geschäftsführer
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Geschäftsführer
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritish140347580001
    WHITLEY, Clare Elizabeth
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    Geschäftsführer
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    British48012620002

    Hat GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A supplemental security, accession and confirmation deed
    Erstellt am 22. Sept. 2011
    Geliefert am 28. Sept. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 2009
    Geliefert am 27. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Dez. 2005
    Geliefert am 17. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 35, 36 and 45 the market covent garden london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 22. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 2005
    Geliefert am 16. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The mortgaged property being unit 35, 36 and 45 the market covent garden london, the plant and machinery, any goodwill, rental and other money payable and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Starlight Investments Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Sept. 2005
    Geliefert am 05. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property at 1 watling street, st paul's, london t/no NGL800172. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 6 whitehouse apartments, 9 belvedere road, southbank t/n TGL165663, hasilwood house, 60/64 bishopsgate t/n NGL751095 and 119/120 chancery lane t/n NGL767272 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 27. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 05. Nov. 2003
    Geliefert am 15. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £62,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    An account set up pursuant to a rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Personal Pension Management Limited
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Mai 2003
    Geliefert am 09. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Okt. 2001
    Geliefert am 30. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer deed
    Erstellt am 29. Okt. 1993
    Geliefert am 15. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charges upon; all the property and/or assets of the company listed on the schedule together with all buildings,fixtures and fixed plant and machinery. All other present and f/h and l/h property of the company all the company's present and future goodwill and uncalled capital. Floating charges upon all theundertaking and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Aug. 1989
    Geliefert am 22. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part basement ground & first floors 11/13 frith st. & 3/5 bateman st. London W1 with fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Aug. 1989
    Geliefert am 22. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground floor & basement 39, panton st. London SW1 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Aug. 1989
    Geliefert am 22. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    44A & 44B floral street london WC2 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1989
    Geliefert am 17. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Juli 1989
    Geliefert am 21. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Twenties publis house, 39, ranelagh grove, london, SW1.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Juli 1989
    Geliefert am 20. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part ground floor and whole of basement, 119/120 chancery lane, london WC2. Together with the fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Juli 1989
    Geliefert am 20. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part 31 dover street london W1 t/n ngl 339791 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Juli 1989
    Geliefert am 20. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    8 charlotte street, fitzroy square, st pancras, london W1. T/n 64653 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1988
    Geliefert am 26. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    44A floral street london WC2.
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1988
    Geliefert am 26. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11-13 frith street london W1.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1988
    Geliefert am 26. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    39 panton street london SW1.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 15. Feb. 1988
    Geliefert am 26. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 12. Aug. 1987
    Geliefert am 26. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as being 11/13 frith street and 3/5 bateman street, london W1 including the entirley of the property comprised is a lease dated 14.10.86 of all buildings & fixtures thereon & by way of assignment the goodwill of the business carried on at the above property & the full benefit of all present and future licences held in connection with the said business or any other business carried on at the above.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1987Registrierung einer Belastung

    Hat GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Nov. 2011Beginn der Verwaltung
    24. Okt. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DatumTyp
    24. Okt. 2012Beginn der Liquidation
    16. Aug. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew David Smith
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0