SUPERIOR FOOD LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUPERIOR FOOD LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02006417 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUPERIOR FOOD LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SUPERIOR FOOD LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUPERIOR FOOD LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SUPERIOR FOODS LIMITED | 02. Mai 1996 | 02. Mai 1996 |
| SPURHART LIMITED | 03. Apr. 1986 | 03. Apr. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPERIOR FOOD LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUPERIOR FOOD LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Johnson als Geschäftsführer am 03. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diarmuid Brendan Conifrey als Geschäftsführer am 24. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Diarmuid Brendan Conifrey als Direktor am 08. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss S1096 Court Order to Rectify | 6 Seiten | OC | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 47 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 29 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ian Tentori als Geschäftsführer am 27. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Cox als Sekretär am 08. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Eliot Cox als Geschäftsführer am 07. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Martin Johnson als Direktor am 25. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Ian Tentori als Direktor am 06. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUPERIOR FOOD LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COX, Gavin | Sekretär | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | 165756710001 | |||||||
| MOMEN, Julian Akhtar Karim | Sekretär | Tanners Drive MK14 5BN Blakelands 28 Milton Keynes | British | 150500890001 | ||||||
| TAYLOR, Michael Dennis | Sekretär | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 18385410004 | ||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Sekretär | One London Wall EC2Y 5AB London | 116685100001 | |||||||
| CHISAMBI, Rodgers Yalamila | Geschäftsführer | Flat 7 30 Longridge Road SW5 9SJ Earls Court London | Zambian | 77986900001 | ||||||
| CONIFREY, Diarmuid Brendan | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 | England | Irish | 268799160001 | |||||
| COX, Gavin Eliot | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | United Kingdom | British | 153840250001 | |||||
| FEE, Paul | Geschäftsführer | 285 Yorktown Road College Town GU47 0QA Sandhurst Berkshire | British | 55281590001 | ||||||
| GUY, David Simon | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | British | 119214340001 | ||||||
| HALL, Fraser Scott | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | British | 4578740001 | ||||||
| HAZELDEAN, William James | Geschäftsführer | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 83660790002 | |||||
| JOHNSON, Martin | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 | England | British | 140167360001 | |||||
| KINGSLEY BATES, Paul | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | United Kingdom | British | 132962170001 | |||||
| MCLELLAND, Stewart | Geschäftsführer | 36 East Craigs Rigg EH12 8JA Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 157009150001 | |||||
| MELLORS, William Peter Stewart | Geschäftsführer | 5 Limetree Court 103 Straight Road SL4 2SS Old Windsor Berkshire | British | 107055640001 | ||||||
| MOMEN, Julian Akhtar Karim | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | England | British | 51784930002 | |||||
| NELSON, Finlay Macarthur | Geschäftsführer | Stamford Road Barnack PE9 3HA Stamford Quarry House Lincolnshire | England | British | 132363820001 | |||||
| NUDDS, Anthony John | Geschäftsführer | 8 Tawny Close TW13 7LH Feltham Middlesex | British | 62512350001 | ||||||
| NUDDS, Anthony John | Geschäftsführer | 8 Tawny Close TW13 7LH Feltham Middlesex | British | 62512350001 | ||||||
| POCOCK, Patrick William | Geschäftsführer | The Steadings Woodside Of Cloghill, Kingswells AB15 8SA Aberdeen | British | 96978470001 | ||||||
| SINCLAIR, John Frederick | Geschäftsführer | 16 Old Coastguard Road Sandbanks BH13 7RL Poole Dorset | British | 17581780001 | ||||||
| SWAINSTON, Keith Graham | Geschäftsführer | 19 Bedford Street SG5 2JG Hitchin Hertfordshire | British | 81821290001 | ||||||
| TAYLOR, Agatha | Geschäftsführer | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 58350880001 | ||||||
| TAYLOR, Michael Dennis | Geschäftsführer | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 18385410004 | ||||||
| TENTORI, Mark Ian | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 | England | British | 119564310001 | |||||
| THOMAS, Christopher | Geschäftsführer | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | England | British | 63844650001 | |||||
| TRUELOVE, Amelia Anne | Geschäftsführer | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | 37845970003 | ||||||
| WEBB, Robert John | Geschäftsführer | 5 Underwood Cottages The Coombe, Streatley RG8 9RA Reading Berkshire | British | 65669490001 | ||||||
| WOOD, Steven John | Geschäftsführer | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | 232132390001 | |||||
| WORT, Edward George | Geschäftsführer | 28 Crown Meadow Colnbrook SL3 0LT Slough Berkshire | British | 77987180001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SUPERIOR FOOD LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Food Group Limited | 06. Apr. 2016 | The Square, Southall Lane UB2 5NH Southall 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SUPERIOR FOOD LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 05. März 2015 Geliefert am 11. März 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 31. Mai 2013 Geliefert am 07. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to superior food limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of superior food limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 31. Mai 2013 Geliefert am 05. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2012 Geliefert am 14. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 11. Apr. 2012 Geliefert am 14. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Apr. 2008 Geliefert am 02. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture accession deed | Erstellt am 16. Feb. 2007 Geliefert am 05. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 14. März 2006 Geliefert am 01. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenant's interest in all the monies standing to the credit of the account including all interest accruing thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 31. Jan. 2006 Geliefert am 09. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 home counties storage system 17D mezzanine floor, 1 home counties storage system 17C mezzanine floor, 1 ima cooling system cold room 17A, for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 08. Jan. 2004 Geliefert am 10. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. März 1999 Geliefert am 01. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Apr. 1994 Geliefert am 05. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Apr. 1994 Geliefert am 05. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 4 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Apr. 1994 Geliefert am 05. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 2 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 19. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Juli 1990 Geliefert am 31. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate dominion road southall middx and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Sept. 1989 Geliefert am 29. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit number 2 feather stone industrial estate southall L.B. of ealing unit number of feather stone industrial estate southall L.B. of ealing and proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0