SUPERIOR FOOD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSUPERIOR FOOD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02006417
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SUPERIOR FOOD LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SUPERIOR FOODS LIMITED02. Mai 199602. Mai 1996
    SPURHART LIMITED03. Apr. 198603. Apr. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Martin Johnson als Geschäftsführer am 03. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Diarmuid Brendan Conifrey als Geschäftsführer am 24. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Diarmuid Brendan Conifrey als Direktor am 08. Apr. 2020

    2 SeitenAP01

    Gerichtsbeschluss

    S1096 Court Order to Rectify
    6 SeitenOC

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    22 SeitenAA

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    22 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    47 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Sept. 2017

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    29 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Mark Ian Tentori als Geschäftsführer am 27. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gavin Cox als Sekretär am 08. März 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Gavin Eliot Cox als Geschäftsführer am 07. März 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Martin Johnson als Direktor am 25. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 09. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Ernennung von Mr Mark Ian Tentori als Direktor am 06. Okt. 2015

    2 SeitenAP01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Agreement 25/09/2015
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Sekretär
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756710001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Sekretär
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500890001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Sekretär
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    CHISAMBI, Rodgers Yalamila
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Geschäftsführer
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Zambian77986900001
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrish268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    FEE, Paul
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    Geschäftsführer
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    British55281590001
    GUY, David Simon
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British119214340001
    HALL, Fraser Scott
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British4578740001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Geschäftsführer
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish83660790002
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish140167360001
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MELLORS, William Peter Stewart
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    British107055640001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    NELSON, Finlay Macarthur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    EnglandBritish132363820001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Geschäftsführer
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    SINCLAIR, John Frederick
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British17581780001
    SWAINSTON, Keith Graham
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    British81821290001
    TAYLOR, Agatha
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British58350880001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Geschäftsführer
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WEBB, Robert John
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    British65669490001
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Geschäftsführer
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    WORT, Edward George
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    Geschäftsführer
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    British77987180001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Superior Food Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06. Apr. 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies
    Registrierungsnummer05288249
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat SUPERIOR FOOD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. März 2015
    Geliefert am 11. März 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 11. März 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 31. Mai 2013
    Geliefert am 07. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to superior food limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of superior food limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 31. Mai 2013
    Geliefert am 05. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2012
    Geliefert am 14. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 07. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2012
    Geliefert am 14. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 07. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 2008
    Geliefert am 02. Mai 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 02. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture accession deed
    Erstellt am 16. Feb. 2007
    Geliefert am 05. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)(the Security Agent)
    Transaktionen
    • 05. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. März 2006
    Geliefert am 01. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant's interest in all the monies standing to the credit of the account including all interest accruing thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Brixton (Great Western,Southall) 1 Limited
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 09. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 home counties storage system 17D mezzanine floor, 1 home counties storage system 17C mezzanine floor, 1 ima cooling system cold room 17A, for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 08. Jan. 2004
    Geliefert am 10. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. März 1999
    Geliefert am 01. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1994
    Geliefert am 05. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1994
    Geliefert am 05. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 4 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1994
    Geliefert am 05. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 2 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Feb. 1994
    Geliefert am 19. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Juli 1990
    Geliefert am 31. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate dominion road southall middx and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 03. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Sept. 1989
    Geliefert am 29. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit number 2 feather stone industrial estate southall L.B. of ealing unit number of feather stone industrial estate southall L.B. of ealing and proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 03. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0