LARGEDOUBLE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLARGEDOUBLE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02009038
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LARGEDOUBLE LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LARGEDOUBLE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Micheldever Tyre Services Limited Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LARGEDOUBLE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für LARGEDOUBLE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Apr. 2018 mit Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA geändert

    1 SeitenAD02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2018 bis 31. Dez. 2017

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2017

    9 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 20. März 2018 bis 31. März 2017

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 20. März 2017

    9 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2017 bis 20. März 2017

    1 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Philip Raymond Stoddart als Geschäftsführer am 21. März 2017

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Jonathan Robert Cowles als Sekretär am 21. März 2017

    3 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Duncan Stewart Wilkes als Direktor am 21. März 2017

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Jonathan Robert Cowles als Direktor am 21. März 2017

    3 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tiers Cross Haverfordwest Pembrokeshire SA62 3DB zum Micheldever Tyre Services Limited Micheldever Station Andover Road Winchester Hampshire SO21 3AP am 05. Apr. 2017

    2 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 020090380016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 020090380015 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LARGEDOUBLE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COWLES, Jonathan Robert
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Sekretär
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    228670660001
    COWLES, Jonathan Robert
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    EnglandBritish122658610002
    WILKES, Duncan Stewart
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    EnglandBritish75861610001
    FLANNERY, Karen
    Redlands Cottage
    Hasguard Cross
    SA62 3SJ Haverfordwest
    Pembrokeshire
    Sekretär
    Redlands Cottage
    Hasguard Cross
    SA62 3SJ Haverfordwest
    Pembrokeshire
    British125088880001
    STODDART, Andrew Michael
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    Sekretär
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    British6030590001
    STODDART, Sara Jane
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    Sekretär
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    British41000880001
    SUTTON, Lucy Marie
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Pembrokeshire
    Sekretär
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Pembrokeshire
    British81443870001
    STODDART, Andrew Michael
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    Geschäftsführer
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    British6030590001
    STODDART, Joan, Director
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    Geschäftsführer
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    British6030600001
    STODDART, Philip Raymond
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Oakleigh House
    Dyfed
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Oakleigh House
    Dyfed
    United Kingdom
    WalesBritish125088870001
    STODDART, Sara Jane
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    Geschäftsführer
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    British41000880001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LARGEDOUBLE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services
    England
    21. März 2017
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer01817398
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Mr Philip Raymond Stoddart
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    10. März 2017
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Wales
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat LARGEDOUBLE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 01. Mai 2013
    Geliefert am 21. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. März 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Mai 2013
    Geliefert am 10. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The property at: leasehold property known as pembroke depot- 4/5 kingswood trading estate, pembroke dock, pembrokeshire under title number: CYM478197.. With the benefit of all rights, licences, guarantees, rent, deposits contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property:. Any shares or membership rights in any management company for the property;. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property;. Any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and. All other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. März 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 10. Nov. 2011
    Geliefert am 19. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H unit 3 parc gwynfryn industrial estate crymych pembrokeshire together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 27. Apr. 2011
    Geliefert am 30. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H part of land lying to the north of a road leading from robeston cross to tiers cross haverfordwest t/n part CYM239886, together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H warehouse east and west at london road mall pembroke dock pembrokeshire together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 30. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 2009
    Geliefert am 24. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Warehouse east & west the london road mall penbroke dock.
    Berechtigte Personen
    • Pendfro Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 15. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Bowens hardware store maenclochog clyderwen pembrokeshire t/no CYM306933. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 29. Nov. 2002
    Geliefert am 04. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as or being the industrial plot at brookside estate withybush haverfordwest title number WA908516. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 22. Nov. 2002
    Geliefert am 04. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as central garage tiers cross haverfordwest title numbers WA759111 and WA764539. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 15. Okt. 2002
    Geliefert am 19. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Feb. 1999
    Geliefert am 02. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 1/3 acre of land at withybush industrial estate haverfordwest. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juni 1995
    Geliefert am 07. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a edwards garage, tiers cross, haverfordwest, dyfed. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juni 1995
    Geliefert am 07. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a central garage, tiers cross, haverfordwest, dyfed. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 02. Juni 1995
    Geliefert am 07. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Mai 1995
    Geliefert am 12. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-property k/a central garage old hakin road tiers cross haverfordwest dyfed t/n-WA690257 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Juli 1987
    Geliefert am 14. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land farmely part of talbenry hall farm talberry dyfed. And/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 07. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0