LTG GATESHEAD GROUP PLC
Überblick
Unternehmensname | LTG GATESHEAD GROUP PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 02010022 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LTG GATESHEAD GROUP PLC?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LTG GATESHEAD GROUP PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o IMAGELINX UK LTD Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby-In-Ashfield NG17 7RB Nottingham United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LTG GATESHEAD GROUP PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CRABTREE GROUP PLC | 21. Juni 1993 | 21. Juni 1993 |
SOMERSET TRUST PLC | 10. Juli 1992 | 10. Juli 1992 |
CHILDREN'S MEDICAL CHARITY INVESTMENT TRUST PLC | 14. Apr. 1986 | 14. Apr. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LTG GATESHEAD GROUP PLC?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LTG GATESHEAD GROUP PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Louise Palmer als Direktor am 16. Nov. 2010 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 5HN am 08. März 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2011 | 13 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Albert Klein als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Albert Kenngott Klein am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b |
Wer sind die Geschäftsführer von LTG GATESHEAD GROUP PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMER, Louise | Sekretär | 12 The Pinfold Glapwell S44 5PU Chesterfield Derbyshire | British | 119011320002 | ||||||
PALMER, Louise | Geschäftsführer | c/o Imagelinx Uk Ltd Lowmoor Road Kirkby-In-Ashfield NG17 7RB Nottingham Julias Way Station Park United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 119011320002 | ||||
RAE, Alistair Kynoch | Geschäftsführer | 45 Lilyville Road SW6 5DP London | England | British | Director | 53806830002 | ||||
BANGE, Udo Karl | Sekretär | 28 Linden Gardens W2 4ES London | German | Director | 69193840001 | |||||
CHESSER, David | Sekretär | Dunkirk House Watling Street NE45 5AQ Corbridge Northumberland | British | Director | 64149560002 | |||||
DAVIDSON, Alan | Sekretär | 80 Haddington Road NE25 9UY Whitley Bay Tyne & Wear | British | Company Director | 30827780001 | |||||
HUNTER, Nicholas James | Sekretär | 1031 Oxford Road RG31 6TL Reading Berkshire | British | Finance Director | 94273950001 | |||||
OURY, Richard Anthony | Sekretär | Farnham Cottage Farnham Common Egypt Lane SL2 3LF Slough Berkshire | British | Accoutant | 29821230002 | |||||
ROWSON, Peter Aston | Sekretär | Croft Lodge Church Lane Great Longstone DE45 1TB Bakewell Derbyshire | British | 94699120001 | ||||||
C S INVESTMENTS LIMITED | Sekretär | 125 High Holborn WC1V 6PY London | 4852550001 | |||||||
THROGMORTON SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 42 Portman Road RG30 1EA Reading Berkshire | 80839850001 | |||||||
ARMSTRONG, Michael John Lloyd | Geschäftsführer | Moor Mill Farm Lydeard,St Lawrence TA4 3RG Taunton Somerset | British | Retired | 48330740002 | |||||
BANGE, Udo Karl | Geschäftsführer | 28 Linden Gardens W2 4ES London | German | Director | 69193840001 | |||||
BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett | Geschäftsführer | 7 Hillingdon Road Whitefield M45 7QQ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | Company Secretary | 2883500001 | ||||
CHESSER, David | Geschäftsführer | Dunkirk House Watling Street NE45 5AQ Corbridge Northumberland | England | British | Director | 64149560002 | ||||
COOPER, Matthew | Geschäftsführer | Newlands Marchburn Lane NE44 6DN Riding Mill Northumberland | United Kingdom | British | Company Secretary | 35122920001 | ||||
DAVIDSON, Alan | Geschäftsführer | 80 Haddington Road NE25 9UY Whitley Bay Tyne & Wear | England | British | Company Director | 30827780001 | ||||
FELLERMAN, Paul | Geschäftsführer | 38 Sherwood Road Hendon NW4 1AD London | British | Stockbroker | 10266750001 | |||||
FLETCHER, Alan Thomas | Geschäftsführer | 26 Loudoun Road NW8 0LT London | British | Company Director | 14669590001 | |||||
HARGRAVE, Stephen Thomas | Geschäftsführer | 47 Lambs Conduit Street WC1N 3NG London | England | British | Company Director | 60918490001 | ||||
HOLMES, John Edwin | Geschäftsführer | 45 Linden Road Darras Hall Ponteland NE20 9DP Newcastle Upon Tyne | British | Managing Director | 42461820001 | |||||
HUNTER, Nicholas James | Geschäftsführer | 1031 Oxford Road RG31 6TL Reading Berkshire | England | British | Financial Director | 94273950001 | ||||
JOHNSON, Luke Oliver | Geschäftsführer | 28 Monmouth Road W2 4UT London | British | Company Director | 56699270001 | |||||
KLEIN, Albert Kenngott | Geschäftsführer | C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield Nottinghamshire | Germany | German | Director | 69826640001 | ||||
LEHRER, Abraham Mayir | Geschäftsführer | 13 Haslemere Gardens N3 3EA London | British | Solicitor | 10008800001 | |||||
LEWINSOHN, Max Robert | Geschäftsführer | Tanyard Manor Horsted Lane RH19 4HY Sharpthorne Sussex | United Kingdom | British | Director | 17400002 | ||||
MOWINCKEL, John Crostarosa, Mr. | Geschäftsführer | Flat 9 30 Bramham Gardens SW5 0HE London | United Kingdom | American | Banker | 42840430001 | ||||
NAPOLEON, Edward | Geschäftsführer | 929 N Astor 1502 Milwaukee Wi 53202 Usa | American | Businessman | 50486960002 | |||||
ODELL, Frank William | Geschäftsführer | 7 Ham Farm Road Ham Common TW10 5ND Richmond Surrey | British | Director | 2081870001 | |||||
ORR, David Alexander, Sir | Geschäftsführer | Home Farm House Shackleford GU8 6AH Godalming Surrey | British | Company Director | 38973090001 | |||||
OURY, Richard Anthony | Geschäftsführer | Farnham Cottage Farnham Common Egypt Lane SL2 3LF Slough Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 29821230002 | ||||
PAUL, Swraj, Dr | Geschäftsführer | Caparo House 103 Baker Street W1M 1FD London | British | Director | 40016170001 | |||||
PERLOFF, Andrew Stewart | Geschäftsführer | Friars Mead Barnet Lane Elstree WD6 3RA Borehamwood Hertfordshire | England | British | Company Director | 1474150001 | ||||
ROGERS, Douglas Ernest | Geschäftsführer | 46 Hampton Lane B91 2PZ Solihull West Midlands | British | Company Director | 32445690002 | |||||
STEVENSON, Samuel | Geschäftsführer | 149 Pavilion Road SW1X 0BJ London | British | Director | 2506760001 |
Hat LTG GATESHEAD GROUP PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed between the company (1) crabtree holdings (us) limited (2) crabtree holdings limited (3) crabtree of gateshead limited (4) and landesbank baden-wurttenberg (the bank) (2) | Erstellt am 12. Juli 1999 Geliefert am 02. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag (A) the secured parties have made available to the companies a loan facility of up to dem 19,800,000 on the terms set out in a facility agreement (the" crabtree facilities agreement") dated 11 november 1998 made between the companies as borrower (1) ltg technologies PLC as guarantor (2) and the chargee (3) for the purpose of refinancing existing loan facilities of the companies.(b) the obligations of the companies to the secured parties under or pursuant to inter alia the crabtree facilities agreement are secured by a composite guarantee and debenture dated 15 december 1998 | |
Kurze Angaben Pursuant to the supplemental deed the debenture has been amended so that schedule 2 (properties),schedule 3 (fixed plant and machinery) and schedule 4 (intellectual property rights) to the debenture are deleted in their entirety and replaced by the respective schedules set out in annexure a of the supplemental deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture between crabtree group PLC (1), crabtree holdings (us) limited (2), crabtree holdings limited (3), crabtree of gateshead limited (4) and landesgirokasse offentliche bank und landessparkasse (the "chargee")(5) | Erstellt am 15. Dez. 1998 Geliefert am 22. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to the "secured documents" (as defined) together and each as it may from time to time be amended varied novated supplemented or replaced | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 27. Nov. 1995 Geliefert am 05. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 13. Okt. 1993 Geliefert am 28. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the deposits, together with all interest from time to time accruing thereon, details of charged deposit contract(s)-barclays bank PLC re spmerset trust PLC (now called crabtree group PLC) gts bid deposit bid number 7568760 (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 23. Juli 1993 Geliefert am 12. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the "deposit (s)", together with all interest from time to time accruing thereon. Details of charged account(s)-barclays bank PLC re crabtree group PLC, bid deposit bid no: 62011466 (for full details see from 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 21. Juni 1993 Geliefert am 12. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re somerset trust PLC gts bid deposit bid no 7568760. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0