LTG GATESHEAD GROUP PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLTG GATESHEAD GROUP PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02010022
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o IMAGELINX UK LTD
    Julias Way Station Park Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CRABTREE GROUP PLC21. Juni 199321. Juni 1993
    SOMERSET TRUST PLC10. Juli 199210. Juli 1992
    CHILDREN'S MEDICAL CHARITY INVESTMENT TRUST PLC14. Apr. 198614. Apr. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    2 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Louise Palmer als Direktor am 16. Nov. 2010

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. März 2012

    Kapitalaufstellung am 08. März 2012

    • Kapital: GBP 2,028,329.9
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 5HN am 08. März 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2011

    13 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Albert Klein als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Albert Kenngott Klein am 01. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    7 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PALMER, Louise
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    British119011320002
    PALMER, Louise
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director119011320002
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Geschäftsführer
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    EnglandBritishDirector53806830002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Sekretär
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Sekretär
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    BritishDirector64149560002
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director30827780001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Sekretär
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    BritishFinance Director94273950001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Sekretär
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    BritishAccoutant29821230002
    ROWSON, Peter Aston
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    Sekretär
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    British94699120001
    C S INVESTMENTS LIMITED
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    Sekretär
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    4852550001
    THROGMORTON SECRETARIES LIMITED
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    Sekretär
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    80839850001
    ARMSTRONG, Michael John Lloyd
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    BritishRetired48330740002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Geschäftsführer
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Secretary2883500001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    EnglandBritishDirector64149560002
    COOPER, Matthew
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Secretary35122920001
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director30827780001
    FELLERMAN, Paul
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    Geschäftsführer
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    BritishStockbroker10266750001
    FLETCHER, Alan Thomas
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Geschäftsführer
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    BritishCompany Director14669590001
    HARGRAVE, Stephen Thomas
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    Geschäftsführer
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    EnglandBritishCompany Director60918490001
    HOLMES, John Edwin
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    BritishManaging Director42461820001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Director94273950001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    Geschäftsführer
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    BritishCompany Director56699270001
    KLEIN, Albert Kenngott
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    GermanyGermanDirector69826640001
    LEHRER, Abraham Mayir
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    Geschäftsführer
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    BritishSolicitor10008800001
    LEWINSOHN, Max Robert
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    Geschäftsführer
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    United KingdomBritishDirector17400002
    MOWINCKEL, John Crostarosa, Mr.
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    Geschäftsführer
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    United KingdomAmericanBanker42840430001
    NAPOLEON, Edward
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    Geschäftsführer
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    AmericanBusinessman50486960002
    ODELL, Frank William
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    BritishDirector2081870001
    ORR, David Alexander, Sir
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director38973090001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant29821230002
    PAUL, Swraj, Dr
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    Geschäftsführer
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    BritishDirector40016170001
    PERLOFF, Andrew Stewart
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director1474150001
    ROGERS, Douglas Ernest
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director32445690002
    STEVENSON, Samuel
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    Geschäftsführer
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    BritishDirector2506760001

    Hat LTG GATESHEAD GROUP PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed between the company (1) crabtree holdings (us) limited (2) crabtree holdings limited (3) crabtree of gateshead limited (4) and landesbank baden-wurttenberg (the bank) (2)
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 02. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    (A) the secured parties have made available to the companies a loan facility of up to dem 19,800,000 on the terms set out in a facility agreement (the" crabtree facilities agreement") dated 11 november 1998 made between the companies as borrower (1) ltg technologies PLC as guarantor (2) and the chargee (3) for the purpose of refinancing existing loan facilities of the companies.(b) the obligations of the companies to the secured parties under or pursuant to inter alia the crabtree facilities agreement are secured by a composite guarantee and debenture dated 15 december 1998
    Kurze Angaben
    Pursuant to the supplemental deed the debenture has been amended so that schedule 2 (properties),schedule 3 (fixed plant and machinery) and schedule 4 (intellectual property rights) to the debenture are deleted in their entirety and replaced by the respective schedules set out in annexure a of the supplemental deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Baden-Wurttenberg (The Successor Entity Following the Merger on 1 January 1999 of Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse,Sudwestdeutsche Landesbank Girozentrale and Landeskreditbank Baden Wurttenberg)
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture between crabtree group PLC (1), crabtree holdings (us) limited (2), crabtree holdings limited (3), crabtree of gateshead limited (4) and landesgirokasse offentliche bank und landessparkasse (the "chargee")(5)
    Erstellt am 15. Dez. 1998
    Geliefert am 22. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to the "secured documents" (as defined) together and each as it may from time to time be amended varied novated supplemented or replaced
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Nov. 1995
    Geliefert am 05. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 13. Okt. 1993
    Geliefert am 28. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the deposits, together with all interest from time to time accruing thereon, details of charged deposit contract(s)-barclays bank PLC re spmerset trust PLC (now called crabtree group PLC) gts bid deposit bid number 7568760 (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 23. Juli 1993
    Geliefert am 12. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the "deposit (s)", together with all interest from time to time accruing thereon. Details of charged account(s)-barclays bank PLC re crabtree group PLC, bid deposit bid no: 62011466 (for full details see from 395).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 21. Juni 1993
    Geliefert am 12. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re somerset trust PLC gts bid deposit bid no 7568760. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0