BIR REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBIR REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02013014
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BIR REALISATIONS LIMITED?

    • (5248) /

    Wo befindet sich BIR REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BIR REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BIRTHDAYS LIMITED28. Nov. 199628. Nov. 1996
    RON WOOD GREETING CARDS LIMITED 04. März 199404. März 1994
    RONWOOD GREETING CARDS LIMITED22. Apr. 198622. Apr. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIR REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Juli 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für BIR REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    31 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Nov. 2012

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Mai 2012

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Nov. 2011

    11 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Mai 2011

    9 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ am 26. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    18 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Nov. 2009

    15 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten287

    Vorschlag des Verwalters

    44 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    14 Seiten2.16B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed birthdays LIMITED\certificate issued on 01/07/09
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    11 Seiten395

    Beschlüsse

    Resolutions
    13 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Juli 2007

    21 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von BIR REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HARTOG, Barry Raymond
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    Sekretär
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    British9892960001
    HARTOG, Barry Raymond
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish9892960001
    LEWIN, Clinton Stuart
    Canes Farm Canes Lane
    Hastingwood
    CM17 9LD Harlow
    Essex
    Geschäftsführer
    Canes Farm Canes Lane
    Hastingwood
    CM17 9LD Harlow
    Essex
    United KingdomBritish1935590001
    LEWIN, Donald John
    Broadoaks High Road
    IG7 6DW Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    Broadoaks High Road
    IG7 6DW Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish1935600002
    KAYE, David Stanley
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    Sekretär
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    British78278710003
    MCKENNA, John
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    British43759940002
    WALKER, Thomas Alexander Goldie
    4 Golf View
    ML10 6AZ Strathaven
    Lanarkshire
    Sekretär
    4 Golf View
    ML10 6AZ Strathaven
    Lanarkshire
    British67798320002
    WOODHOUSE, Christopher Kevin
    Oakleigh
    62 Station Road
    BL7 0HA Chapletown
    Turton Bolton
    Sekretär
    Oakleigh
    62 Station Road
    BL7 0HA Chapletown
    Turton Bolton
    British48827150001
    BEESLEY, Nicholas William
    Waverley 22 Abbey Road
    West Kirby
    L48 7EW Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Waverley 22 Abbey Road
    West Kirby
    L48 7EW Wirral
    Merseyside
    British54212890002
    BOLAND, Richard Paul
    Hillfoot Cottage
    25 Uttoxeter Road
    WS15 3QR Hill Ridware Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Hillfoot Cottage
    25 Uttoxeter Road
    WS15 3QR Hill Ridware Rugeley
    Staffordshire
    British92472430001
    CARTER, Nicholas Michael
    Laverton House
    Laverton
    WR12 7NA Broadway
    Worcs
    Geschäftsführer
    Laverton House
    Laverton
    WR12 7NA Broadway
    Worcs
    EnglandBritish120830070001
    COOKE, Nicholas John
    35 Gingerbread Lane
    CW5 6NH Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    35 Gingerbread Lane
    CW5 6NH Nantwich
    Cheshire
    British22741440001
    DAVIS, Andrew Guy
    50 Somerset Grove
    OL11 5YS Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    50 Somerset Grove
    OL11 5YS Rochdale
    Lancashire
    United KingdomBritish79007370001
    DUXBURY, Nigel David
    7 Holkar Meadows
    Bromley Cross
    BL7 9NA Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Holkar Meadows
    Bromley Cross
    BL7 9NA Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish92190030001
    FORDE, Hugh Aloysius
    217 Medlock Road
    Woodhouses Failsworth
    M35 9NQ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    217 Medlock Road
    Woodhouses Failsworth
    M35 9NQ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish95092810001
    JACKSON, Carl William
    Riverside Cottage Main Street
    Burnsall
    BD23 6BN Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Riverside Cottage Main Street
    Burnsall
    BD23 6BN Skipton
    North Yorkshire
    British67237250002
    LOVERING, John David
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    Geschäftsführer
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    United KingdomBritish73573160002
    MASON, Stephen Antony
    303 Haslingden Road
    BB4 6RX Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    303 Haslingden Road
    BB4 6RX Rossendale
    Lancashire
    British70769560001
    MCAULEY, Charles
    Witchingham Apartment 8
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Witchingham Apartment 8
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    British53076620002
    MCCLUSKEY, Brian
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    United KingdomBritish96335270001
    MCKAY, Robert
    25 Mimosa Close
    Euxton
    PR7 1BT Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    25 Mimosa Close
    Euxton
    PR7 1BT Chorley
    Lancashire
    British99969890001
    MCKENNA, John
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish43759940002
    NASH, Jeffrey Nigel
    Lane Rigg 148 Thornhill Road
    B74 2EH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Lane Rigg 148 Thornhill Road
    B74 2EH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British11989260001
    PREECE, Ian
    Stiggits Barn Annfield Mains
    KY15 7TW Kettlehill
    Fife
    Geschäftsführer
    Stiggits Barn Annfield Mains
    KY15 7TW Kettlehill
    Fife
    ScotlandBritish58430560001
    RICHARDS, Jeffrey
    42 Rookery Rise
    Swallowfield Estate
    CW7 3EA Winsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    42 Rookery Rise
    Swallowfield Estate
    CW7 3EA Winsford
    Cheshire
    British54212990001
    RISK, Keith James
    10 Lyndale Park
    Orton Wistow
    PE2 6FE Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    10 Lyndale Park
    Orton Wistow
    PE2 6FE Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish74726270001
    ROBSON, Bryan
    Clovelly 108 Bankhall Lane
    Hale
    WA15 0PD Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Clovelly 108 Bankhall Lane
    Hale
    WA15 0PD Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish7889130001
    ROME, Ronald
    Holly Cottage
    Tarnsphurst Lane
    CHESHIRE Hazel Grove
    Stockport
    Geschäftsführer
    Holly Cottage
    Tarnsphurst Lane
    CHESHIRE Hazel Grove
    Stockport
    British75311740001
    SHARPLES, Michael
    6 Whitebirk Close
    Greenmount
    BL8 4HE Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    6 Whitebirk Close
    Greenmount
    BL8 4HE Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish4474120001
    SHEPHERD, Edward
    3 Ramwells Court
    Windy Harbour Lane, Bromley Cross
    BL7 9PH Bolton
    Geschäftsführer
    3 Ramwells Court
    Windy Harbour Lane, Bromley Cross
    BL7 9PH Bolton
    United KingdomBritish69015160002
    SHERMAN, Stephen Andrew
    Victorian Lanterns
    16 Miller Street
    BL9 5PX Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victorian Lanterns
    16 Miller Street
    BL9 5PX Bury
    Lancashire
    British69801240001
    SMITH, Michael Joseph
    9 Browgate
    Sawley
    BB7 4LE Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    9 Browgate
    Sawley
    BB7 4LE Clitheroe
    Lancashire
    British29439000002
    TAPP, Christopher
    17 High Street
    Easton On The Hill
    PE9 3LN Stamford
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Easton On The Hill
    PE9 3LN Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish65723190003
    WALTERS, Nicholas John
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    Geschäftsführer
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    British38462890002
    WOOD, Gail Elizabeth
    Woodlands 23 Station Road
    BL8 4BJ Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Woodlands 23 Station Road
    BL8 4BJ Bury
    Lancashire
    EnglandBritish50668920001

    Hat BIR REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each debtor to the charge or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charges, assignments and floating charge see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A share charge
    Erstellt am 23. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each debtor to the charge or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charges assignments and floating charge see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Aug. 2003
    Geliefert am 17. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • A
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Eachother Finance Party
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 29. Aug. 2003
    Geliefert am 18. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge the chargors shares in birthdays (ireland) limited together with any substituted securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Eachfinance Party
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 15. Nov. 1999
    Geliefert am 26. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale (As Security Agent for the Security Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 21. Okt. 1996
    Geliefert am 30. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at barlow fold lying to the west of manchester rd,bury; t/nos: la 340783 and gm 471200; land to the north of bridge hall lane,bury; gm 504900 and land on north west side of dummers lane,bury; gm 548027,gm 685848 and gm 694191. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Aug. 1993
    Geliefert am 09. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-land on the north west side of dumers lane bury greater manchester. T/n-GM548027. And/or the proceeds of sale thereof and assigns the good will ofthe business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assurance
    Erstellt am 25. Aug. 1993
    Geliefert am 27. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the covenants contained in the assurance dated 25 august 1993
    Kurze Angaben
    L/H-106 high stree margate.
    Berechtigte Personen
    • Dixon Stores Group Limited and Currys Group PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assurance
    Erstellt am 25. Aug. 1993
    Geliefert am 27. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the covenants contained in the assurance dated 25 august 1993
    Kurze Angaben
    L/H-39 high street ramsgate.
    Berechtigte Personen
    • Dixons Stores Group Limited and Currys Group PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Apr. 1992
    Geliefert am 27. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that plot of land situate to the north of bridge hall lane, bury title no gm 504900 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. März 1988
    Geliefert am 18. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H whitehouse service station manchester road bury grt manchester and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 12. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Aug. 1986
    Geliefert am 11. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at barlow fold lying to the west of manchester road bury greater manchester title no la 340783 and/or the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    • 12. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. Juni 1986
    Geliefert am 04. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties &/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property andassets present and future including goodwill, bookdebts & the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    • 12. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BIR REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Mai 2010Ende der Verwaltung
    20. Mai 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Praktiker
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    26. Okt. 2013Aufgelöst am
    11. Mai 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0