BIR REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BIR REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02013014 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BIR REALISATIONS LIMITED?
- (5248) /
Wo befindet sich BIR REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Zenith Building 26 Spring Gardens M2 1AB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BIR REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BIRTHDAYS LIMITED | 28. Nov. 1996 | 28. Nov. 1996 |
| RON WOOD GREETING CARDS LIMITED | 04. März 1994 | 04. März 1994 |
| RONWOOD GREETING CARDS LIMITED | 22. Apr. 1986 | 22. Apr. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIR REALISATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Juli 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BIR REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 31 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Nov. 2012 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Mai 2012 | 10 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Nov. 2011 | 11 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Mai 2011 | 9 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ am 26. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 18 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Nov. 2009 | 15 Seiten | 2.24B | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 44 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 14 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed birthdays LIMITED\certificate issued on 01/07/09 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Juli 2007 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BIR REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARTOG, Barry Raymond | Sekretär | 54 Woodcock Hill Kenton HA3 0JF Harrow Middlesex | British | 9892960001 | ||||||
| HARTOG, Barry Raymond | Geschäftsführer | 54 Woodcock Hill Kenton HA3 0JF Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 9892960001 | |||||
| LEWIN, Clinton Stuart | Geschäftsführer | Canes Farm Canes Lane Hastingwood CM17 9LD Harlow Essex | United Kingdom | British | 1935590001 | |||||
| LEWIN, Donald John | Geschäftsführer | Broadoaks High Road IG7 6DW Chigwell Essex | United Kingdom | British | 1935600002 | |||||
| KAYE, David Stanley | Sekretär | 3 Egidia Avenue Giffnock G46 7NH Glasgow | British | 78278710003 | ||||||
| MCKENNA, John | Sekretär | 12 Streamside Close Timperley WA15 7PE Altrincham Cheshire | British | 43759940002 | ||||||
| WALKER, Thomas Alexander Goldie | Sekretär | 4 Golf View ML10 6AZ Strathaven Lanarkshire | British | 67798320002 | ||||||
| WOODHOUSE, Christopher Kevin | Sekretär | Oakleigh 62 Station Road BL7 0HA Chapletown Turton Bolton | British | 48827150001 | ||||||
| BEESLEY, Nicholas William | Geschäftsführer | Waverley 22 Abbey Road West Kirby L48 7EW Wirral Merseyside | British | 54212890002 | ||||||
| BOLAND, Richard Paul | Geschäftsführer | Hillfoot Cottage 25 Uttoxeter Road WS15 3QR Hill Ridware Rugeley Staffordshire | British | 92472430001 | ||||||
| CARTER, Nicholas Michael | Geschäftsführer | Laverton House Laverton WR12 7NA Broadway Worcs | England | British | 120830070001 | |||||
| COOKE, Nicholas John | Geschäftsführer | 35 Gingerbread Lane CW5 6NH Nantwich Cheshire | British | 22741440001 | ||||||
| DAVIS, Andrew Guy | Geschäftsführer | 50 Somerset Grove OL11 5YS Rochdale Lancashire | United Kingdom | British | 79007370001 | |||||
| DUXBURY, Nigel David | Geschäftsführer | 7 Holkar Meadows Bromley Cross BL7 9NA Bolton Lancashire | England | British | 92190030001 | |||||
| FORDE, Hugh Aloysius | Geschäftsführer | 217 Medlock Road Woodhouses Failsworth M35 9NQ Manchester Lancashire | England | British | 95092810001 | |||||
| JACKSON, Carl William | Geschäftsführer | Riverside Cottage Main Street Burnsall BD23 6BN Skipton North Yorkshire | British | 67237250002 | ||||||
| LOVERING, John David | Geschäftsführer | New House Farm Bodiam TN32 5UP Robertsbridge East Sussex | United Kingdom | British | 73573160002 | |||||
| MASON, Stephen Antony | Geschäftsführer | 303 Haslingden Road BB4 6RX Rossendale Lancashire | British | 70769560001 | ||||||
| MCAULEY, Charles | Geschäftsführer | Witchingham Apartment 8 Adlington Road SK9 2AL Wilmslow Cheshire | British | 53076620002 | ||||||
| MCCLUSKEY, Brian | Geschäftsführer | 5 Ayr Road KA9 1SX Prestwick Ayrshire | United Kingdom | British | 96335270001 | |||||
| MCKAY, Robert | Geschäftsführer | 25 Mimosa Close Euxton PR7 1BT Chorley Lancashire | British | 99969890001 | ||||||
| MCKENNA, John | Geschäftsführer | 12 Streamside Close Timperley WA15 7PE Altrincham Cheshire | England | British | 43759940002 | |||||
| NASH, Jeffrey Nigel | Geschäftsführer | Lane Rigg 148 Thornhill Road B74 2EH Sutton Coldfield West Midlands | British | 11989260001 | ||||||
| PREECE, Ian | Geschäftsführer | Stiggits Barn Annfield Mains KY15 7TW Kettlehill Fife | Scotland | British | 58430560001 | |||||
| RICHARDS, Jeffrey | Geschäftsführer | 42 Rookery Rise Swallowfield Estate CW7 3EA Winsford Cheshire | British | 54212990001 | ||||||
| RISK, Keith James | Geschäftsführer | 10 Lyndale Park Orton Wistow PE2 6FE Peterborough Cambridgeshire | England | British | 74726270001 | |||||
| ROBSON, Bryan | Geschäftsführer | Clovelly 108 Bankhall Lane Hale WA15 0PD Altrincham Cheshire | England | British | 7889130001 | |||||
| ROME, Ronald | Geschäftsführer | Holly Cottage Tarnsphurst Lane CHESHIRE Hazel Grove Stockport | British | 75311740001 | ||||||
| SHARPLES, Michael | Geschäftsführer | 6 Whitebirk Close Greenmount BL8 4HE Bury Lancashire | United Kingdom | British | 4474120001 | |||||
| SHEPHERD, Edward | Geschäftsführer | 3 Ramwells Court Windy Harbour Lane, Bromley Cross BL7 9PH Bolton | United Kingdom | British | 69015160002 | |||||
| SHERMAN, Stephen Andrew | Geschäftsführer | Victorian Lanterns 16 Miller Street BL9 5PX Bury Lancashire | British | 69801240001 | ||||||
| SMITH, Michael Joseph | Geschäftsführer | 9 Browgate Sawley BB7 4LE Clitheroe Lancashire | British | 29439000002 | ||||||
| TAPP, Christopher | Geschäftsführer | 17 High Street Easton On The Hill PE9 3LN Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 65723190003 | |||||
| WALTERS, Nicholas John | Geschäftsführer | 8 Garrick Avenue Newton Mearns Mearnskirk G77 5GF Glasgow | British | 38462890002 | ||||||
| WOOD, Gail Elizabeth | Geschäftsführer | Woodlands 23 Station Road BL8 4BJ Bury Lancashire | England | British | 50668920001 |
Hat BIR REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. März 2009 Geliefert am 06. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each debtor to the charge or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charges, assignments and floating charge see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A share charge | Erstellt am 23. März 2009 Geliefert am 06. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each debtor to the charge or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charges assignments and floating charge see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Aug. 2003 Geliefert am 17. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 29. Aug. 2003 Geliefert am 18. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge the chargors shares in birthdays (ireland) limited together with any substituted securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 15. Nov. 1999 Geliefert am 26. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 21. Okt. 1996 Geliefert am 30. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at barlow fold lying to the west of manchester rd,bury; t/nos: la 340783 and gm 471200; land to the north of bridge hall lane,bury; gm 504900 and land on north west side of dummers lane,bury; gm 548027,gm 685848 and gm 694191. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 31. Aug. 1993 Geliefert am 09. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-land on the north west side of dumers lane bury greater manchester. T/n-GM548027. And/or the proceeds of sale thereof and assigns the good will ofthe business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assurance | Erstellt am 25. Aug. 1993 Geliefert am 27. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the covenants contained in the assurance dated 25 august 1993 | |
Kurze Angaben L/H-106 high stree margate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assurance | Erstellt am 25. Aug. 1993 Geliefert am 27. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the covenants contained in the assurance dated 25 august 1993 | |
Kurze Angaben L/H-39 high street ramsgate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Apr. 1992 Geliefert am 27. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that plot of land situate to the north of bridge hall lane, bury title no gm 504900 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. März 1988 Geliefert am 18. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H whitehouse service station manchester road bury grt manchester and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Aug. 1986 Geliefert am 11. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at barlow fold lying to the west of manchester road bury greater manchester title no la 340783 and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 25. Juni 1986 Geliefert am 04. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties &/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property andassets present and future including goodwill, bookdebts & the benefit of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BIR REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0