LTG GATESHEAD LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LTG GATESHEAD LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02018906 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LTG GATESHEAD LIMITED?
- (2852) /
Wo befindet sich LTG GATESHEAD LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BEGBIES TRAYNOR CENTRAL LLP 32 Cornhill EC3V 3BT London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LTG GATESHEAD LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LTG 5 LIMITED | 20. März 2003 | 20. März 2003 |
| CRABTREE OF GATESHEAD LTD | 12. Nov. 1986 | 12. Nov. 1986 |
| CARLIOT LIMITED | 12. Mai 1986 | 12. Mai 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LTG GATESHEAD LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2006 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Okt. 2007 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2005 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für LTG GATESHEAD LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Feb. 2017 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 07. März 2017 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LTG GATESHEAD LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für LTG GATESHEAD LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Throgmorton Secretaries Limited als Sekretär am 30. Apr. 2008 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:form 4.40 - notice of ceasing to act as voluntary liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 12 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 244 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LTG GATESHEAD LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMER, Louise | Sekretär | 58 The Hill Glapwell S44 5LY Chesterfield Derbyshire | British | 118087000001 | ||||||
| KLEIN, Albert Kenngott | Geschäftsführer | 45 Albert Hall Mansions Kensington Gore SW7 2AW London | Germany | German | 69826640001 | |||||
| BANGE, Udo Karl | Sekretär | 28 Linden Gardens W2 4ES London | German | 69193840001 | ||||||
| CHESSER, David | Sekretär | Dunkirk House Watling Street NE45 5AQ Corbridge Northumberland | British | 64149560002 | ||||||
| COOPER, Matthew | Sekretär | Newlands Marchburn Lane NE44 6DN Riding Mill Northumberland | British | 35122920001 | ||||||
| DAVIDSON, Alan | Sekretär | 80 Haddington Road NE25 9UY Whitley Bay Tyne & Wear | British | 30827780001 | ||||||
| HUNTER, Nicholas James | Sekretär | 1031 Oxford Road RG31 6TL Reading Berkshire | British | 94273950001 | ||||||
| THROGMORTON SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 42 Portman Road RG30 1EA Reading Berkshire | 80839850001 | |||||||
| BANGE, Udo Karl | Geschäftsführer | 28 Linden Gardens W2 4ES London | German | 69193840001 | ||||||
| COOPER, Matthew | Geschäftsführer | Newlands Marchburn Lane NE44 6DN Riding Mill Northumberland | United Kingdom | British | 35122920001 | |||||
| HARGRAVE, Stephen Thomas | Geschäftsführer | 47 Lambs Conduit Street WC1N 3NG London | England | British | 60918490001 | |||||
| HOLMES, John Edwin | Geschäftsführer | 45 Linden Road Darras Hall Ponteland NE20 9DP Newcastle Upon Tyne | British | 42461820001 | ||||||
| HUNTER, Nicholas James | Geschäftsführer | 1031 Oxford Road RG31 6TL Reading Berkshire | England | British | 94273950001 | |||||
| JOHNSON, Luke Oliver | Geschäftsführer | 28 Monmouth Road W2 4UT London | British | 56699270001 | ||||||
| MCDOWELL, Stephen | Geschäftsführer | 29 Farne Avenue Red House Farm Gosforth NE3 2BJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 87525450001 | ||||||
| OURY, Richard Anthony | Geschäftsführer | Farnham Cottage Farnham Common Egypt Lane SL2 3LF Slough Berkshire | England | British | 29821230002 | |||||
| STEVEN, Andrew, Dr | Geschäftsführer | Barlow Lane End Lead Road Greenside NE40 4RQ Ryton On Tyne Tyne & Wear | British | 77572560001 | ||||||
| WATKIN, Karl Eric | Geschäftsführer | Syllheugh Longhorsley Morpeth NE65 8RF Northumberland | English | 28095460001 | ||||||
| WILLIAMSON, Michael | Geschäftsführer | 222 Sheen Lane East Sheen SW14 8LB London | British | 90174630001 | ||||||
| ZIEGENBEIN, Kristian Axel | Geschäftsführer | 11 Runnymede Road Darras Hall NE20 9HE Ponteland Newcastle Upon Tyne | German | 67297990002 |
Hat LTG GATESHEAD LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 17. Mai 2002 Geliefert am 18. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed between the company (1) crabtree holdings (us) limited (2) crabtree holdings limited (3) crabtree of gateshead limited (4) and landesbank baden-wurttenberg (the bank) (2) | Erstellt am 12. Juli 1999 Geliefert am 02. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag (A) the secured parties have made available to the companies a loan facility of up to dem 19,800,000 on the terms set out in a facility agreement (the" crabtree facilities agreement") dated 11 november 1998 made between the companies as borrower (1) ltg technologies PLC as guarantor (2) and the chargee (3) for the purpose of refinancing existing loan facilities of the companies.(b) the obligations of the companies to the secured parties under or pursuant to inter alia the crabtree facilities agreement are secured by a composite guarantee and debenture dated 15 december 1998 | |
Kurze Angaben Pursuant to the supplemental deed the debenture has been amended so that schedule 2 (properties),schedule 3 (fixed plant and machinery) and schedule 4 (intellectual property rights) to the debenture are deleted in their entirety and replaced by the respective schedules set out in annexure a of the supplemental deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture between crabtree group PLC (1), crabtree holdings (us) limited (2), crabtree holdings limited (3), crabtree of gateshead limited (4) and landesgirokasse offentliche bank und landessparkasse (the "chargee")(5) | Erstellt am 15. Dez. 1998 Geliefert am 22. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to the "secured documents" (as defined) together and each as it may from time to time be amended varied novated supplemented or replaced | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Apr. 1990 Geliefert am 04. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juni 1988 Geliefert am 09. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Okt. 1986 Geliefert am 13. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property described in three underleases dated 13.9.63, 29.3.62, 11.12.70 and an underlease and supplemental deed dated 22.11.65. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 1986 Geliefert am 13. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1.35 million | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 1986 Geliefert am 01. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LTG GATESHEAD LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0