GOLDACRE (OFFICES) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGOLDACRE (OFFICES) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02021103
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BOURNE END PROPERTIES (OFFICES) LIMITED24. Nov. 199324. Nov. 1993
    DAWNAY, DAY PROPERTIES PLC11. März 199111. März 1991
    DRAWPLUS LIMITED20. Mai 198620. Mai 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis24. März 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    9 Seiten4.72

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Sept. 2013

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Aug. 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2013

    21 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B

    10 Seiten2.16B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012

    22 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    28 Seiten2.17B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    2 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    27 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 3Rd Floor 5 Wigmore Street London W1U 1PB* am 04. Apr. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 24. März 2011

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2011

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Aug. 2011

    Kapitalaufstellung am 22. Aug. 2011

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 24. März 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 28. Juli 2010

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH04

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer6745658
    135533720001
    PINCUS, Barry Martin
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    British46444010001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Sekretär
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    British127658820001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Sekretär
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    WARD, Geoffrey Colin Neville
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    Sekretär
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    British67300170001
    BAIN, Duncan Whiteford Taylor
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    British28099480001
    HANCOCK, Christopher
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Geschäftsführer
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    EnglandBritish87069290001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Geschäftsführer
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Geschäftsführer
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Geschäftsführer
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NOE, Leopold
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    EnglandBritish64965010001
    NOE, Philip Martin
    97 Bridge Lane
    NW11 0EE London
    Geschäftsführer
    97 Bridge Lane
    NW11 0EE London
    United KingdomBritish156342420001
    PINCUS, Barry Martin
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    British46444010001
    ROBERTS, David Ian
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    British38276960001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Geschäftsführer
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Geschäftsführer
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat GOLDACRE (OFFICES) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fifteenth supplemental trust deed
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 05. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest of the £75,000,000 10 3/4 per cent.first mortgage debenture stock 2025 of ashpol PLC and all other monies intended to be secured by the deed and the ptincipal trust deed dated 6 december 1985 and deeds supplemental thereto of various dates
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land and buildings on the north west side of london road harlow essex t/no ex 532570. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 24. Juni 1998
    Geliefert am 14. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996
    Kurze Angaben
    193-209 (odd) fleet road fleet hampshire t/no.HP315793 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed
    Erstellt am 10. Okt. 1997
    Geliefert am 25. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member (as defined) to the chargee; as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996
    Kurze Angaben
    F/H property k/a being land on seamer road scarborough north yorkshire together with all buildings erections and fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Form of supplemental deed
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 15. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee supplemental to the deed of legal charge dated 17TH september 1996 and a standard security dated 17TH september 1996
    Kurze Angaben
    The properties listed below together with all buildings erections fixtures fixed plant and machinery. Gosforth valley shopping centre portland road dronfield t/no. DY242772. 448,450,452 & 454 high road tottenham haringey MX90275 and MX267467. 242/262 fleet road (even) fleet hampshire t/no. HP463772. 91 cranby street leicester t/no. LT44946. 16 chatham street leicester t/no. LT29268. Land and buildings on the south east side of chatham street and the north west side of york street leicester t/no. LT38753.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1996
    Erworben am 27. Nov. 1997
    Geliefert am 17. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £66,943,075 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Freehold properties:- (I) 42-46 upper parliament st,nottingham;t/no nt 134743; (ii) staveton house,east hampstead rd,wokingham; t/nos: sk 159854 and bk 222469; (iii) anchor mills,stockton st,hartlepool; t/no bm 202556; (iv) haybarn house,116-118 south st,dorking; t/no sy 419077; (v) alpha numeric house,72 furlong rd,bourne end; t/no bm 172657 and the l/hold property known as sword house,high wycombr; t/no bm 202556.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1997Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1996
    Geliefert am 01. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bourne end properties PLC and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of bourne end properties PLC to the chargee on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south side of drayton road shirley k/a drayton house drayton road shirley solihull west midlands t/n WK152502 and land and buildings k/a 148/152 west end lane and land to the rear of I52 west end lane hampstead t/n's LN238327,NGL167269,NGL167270,NGL158341,NGL458342,NGL328222 and NGL23135 and various other properties (see form 395) and by way of floating charge all the company's assets rights and revenues including uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 1994
    Geliefert am 20. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £11,523,100 and all other monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the "principal deeds" (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of collateral charge
    Erstellt am 25. März 1994
    Geliefert am 08. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from goldacre investments limited to the chargee under the terms of the principal deeds (as defined) and this collateral charge
    Kurze Angaben
    Various l/hold and f/hold properties listed on form 395.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 21. Dez. 1993
    Geliefert am 08. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as dawnay day properties LTD.) and/or euroview investments limited under the terms of the principal deeds (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    Various properties as specified. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 1991
    Geliefert am 04. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £12,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/Hold land at tollhouse hill, nottingham with buildings thereon known as city gate, tollhouse hill nottingham t/no nt 82283.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 1991
    Geliefert am 27. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over f/hold chaucer house, isambard brunel road, portsmouth t/no. Hp 231553 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 07. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 1991
    Geliefert am 27. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £5,150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Kurze Angaben
    F/Hold - chaucer house isambard brunel road portsmouth t/no hp 231553.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 27. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Dez. 1990
    Geliefert am 17. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £4,300,000 and all other monies due or to become due from athe company to the chargee. Under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    F/H land abutting cumberland place, southampton together with buildings k/a grosvenor house, 18-20 cumberland place, southampton.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 26. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Dez. 1990
    Geliefert am 09. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £6,250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land to the south east of rhodaus town, canterbury k/a clarkson house and land adjoining and land to the rear of 22 old dover road rhodaus town canterbury title nos K78007, k 593099, K359160, K71352 & k 596197.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Sept. 1990
    Geliefert am 18. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £2,100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the chargee.
    Kurze Angaben
    F/Hold land abutting camden high street including 97 and 99 camden high street L.B. of camden t/no ngl 356660.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Juni 1990
    Geliefert am 21. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ige Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 21. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further charge
    Erstellt am 01. Juni 1990
    Geliefert am 12. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the existing security (as defined) and this charge.
    Kurze Angaben
    Properties as follows:- first freehold property known as drayton house drayton road shirley solihull-registered under title no sgl 218598. secondly leasehold premises known as 150 and 152 west end lane and land at rear of 152 west end lane hampstead london borough of camden registered under title no ngl 23135. thirdly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease date 15 1 1964 - registered under title no ln 238327. fourthly premises at the rear of 146 and 146A west end lane hampstead aforesaid. As comprised in a lease dated 3 10 1975 registered under title no ngl 458342 fifthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 1 11 1977 registered under title no ngl 458341. sixthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 18 6 1986 and made between the british railways board (1) malacarp terrazzo co LTD acting by the direction of j m iredale and s p l mahon (2) seventhly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 registered under title no ngl 167270 eighthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 - registered under title no ngl 167269.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transaktionen
    • 12. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 1990
    Geliefert am 18. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    97/99 camden high street camden, L.B. of camden t/no ngl 356660.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juli 1989
    Geliefert am 18. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from stencroft properties limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The workshop, 3 blackburn road, hampstead, l/b of camden including all buildings, fixtures (including trade) fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Trust Bank
    Transaktionen
    • 18. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 26. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. März 1989
    Geliefert am 05. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    104 west end lane hampstead. (Fixed charge only).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 26. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral charge
    Erstellt am 29. Sept. 1988
    Geliefert am 03. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,380,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of a legal charge dated 23/10/86 and this charge
    Kurze Angaben
    Four head leases in respect of land & buildings lying to the east of west end lane hampstead title no: ngl 458342 ngl 458341, ln 238327 and two under leases title nos ngl 167269 and ngl 167270 (for details see form 395 and continuation sheet).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,380,000
    Kurze Angaben
    The properties specified on the form M395 title nos: sgl 218598 wk 152502; ngl 23135.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Okt. 1986
    Geliefert am 25. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The properties specified on form M395 together with all fixed machinery buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878, together with all book and other debts in connection with the business.
    Berechtigte Personen
    • Mount Credit Corporation LTD
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 28. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GOLDACRE (OFFICES) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. März 2012Beginn der Verwaltung
    10. Sept. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2
    DatumTyp
    10. Sept. 2013Beginn der Liquidation
    23. Sept. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0