GOLDACRE (OFFICES) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GOLDACRE (OFFICES) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02021103 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
- (7020) /
Wo befindet sich GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 32 Cornhill EC3V 3BT London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BOURNE END PROPERTIES (OFFICES) LIMITED | 24. Nov. 1993 | 24. Nov. 1993 |
| DAWNAY, DAY PROPERTIES PLC | 11. März 1991 | 11. März 1991 |
| DRAWPLUS LIMITED | 20. Mai 1986 | 20. Mai 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 24. März 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 9 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Sept. 2013 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Aug. 2013 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2013 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2013 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 10 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012 | 22 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 28 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 2 Seiten | 2.23B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 27 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 3Rd Floor 5 Wigmore Street London W1U 1PB* am 04. Apr. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. März 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2011 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. März 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 28. Juli 2010 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | 57/63 Line Wall Road Gibraltar Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135533720001 | ||||||||||
| PINCUS, Barry Martin | Sekretär | 35 Newberries Avenue WD7 7EJ Radlett Hertfordshire | British | 46444010001 | ||||||||||
| SHEPPARD, Martin Paul | Sekretär | 53 Etchingham Park Road N3 2EB London | British | 127658820001 | ||||||||||
| SMITH, Ivor | Sekretär | 1 Bridge Lane NW11 0EA London | British | 21120940001 | ||||||||||
| WARD, Geoffrey Colin Neville | Sekretär | 131 Bishopsteignton Shoeburyness SS3 8BQ Southend On Sea Essex | British | 67300170001 | ||||||||||
| BAIN, Duncan Whiteford Taylor | Geschäftsführer | St Huberts Hill Marley Common GU27 3PT Haslemere Surrey | British | 28099480001 | ||||||||||
| HANCOCK, Christopher | Geschäftsführer | Kynnersley Park Road Stoke Poges SL2 4PG Slough | England | British | 87069290001 | |||||||||
| KLIMT, Peter Richard | Geschäftsführer | Redington Road NW3 7RS London 54 | United Kingdom | British | 23621230001 | |||||||||
| MCGRATH, Kevin David | Geschäftsführer | 19 Elm Avenue W5 3XA London | England | British | 83872490002 | |||||||||
| NAGGAR, Guy Anthony | Geschäftsführer | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | 1496660001 | |||||||||
| NOE, Leopold | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | England | British | 64965010001 | |||||||||
| NOE, Philip Martin | Geschäftsführer | 97 Bridge Lane NW11 0EE London | United Kingdom | British | 156342420001 | |||||||||
| PINCUS, Barry Martin | Geschäftsführer | 35 Newberries Avenue WD7 7EJ Radlett Hertfordshire | British | 46444010001 | ||||||||||
| ROBERTS, David Ian | Geschäftsführer | Old Brookside House Winkfield Road SL5 7LX Ascot Berkshire | British | 38276960001 | ||||||||||
| SHEPPARD, Martin Paul | Geschäftsführer | 53 Etchingham Park Road N3 2EB London | United Kingdom | British | 127658820001 | |||||||||
| SMITH, Ivor | Geschäftsführer | 1 Bridge Lane NW11 0EA London | British | 21120940001 | ||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat GOLDACRE (OFFICES) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fifteenth supplemental trust deed | Erstellt am 02. Sept. 2005 Geliefert am 05. Sept. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The principal of and interest of the £75,000,000 10 3/4 per cent.first mortgage debenture stock 2025 of ashpol PLC and all other monies intended to be secured by the deed and the ptincipal trust deed dated 6 december 1985 and deeds supplemental thereto of various dates | |
Kurze Angaben F/H land k/a land and buildings on the north west side of london road harlow essex t/no ex 532570. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 24. Juni 1998 Geliefert am 14. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996 | |
Kurze Angaben 193-209 (odd) fleet road fleet hampshire t/no.HP315793 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 10. Okt. 1997 Geliefert am 25. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group member (as defined) to the chargee; as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996 | |
Kurze Angaben F/H property k/a being land on seamer road scarborough north yorkshire together with all buildings erections and fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Form of supplemental deed | Erstellt am 03. Okt. 1996 Geliefert am 15. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group member to the chargee supplemental to the deed of legal charge dated 17TH september 1996 and a standard security dated 17TH september 1996 | |
Kurze Angaben The properties listed below together with all buildings erections fixtures fixed plant and machinery. Gosforth valley shopping centre portland road dronfield t/no. DY242772. 448,450,452 & 454 high road tottenham haringey MX90275 and MX267467. 242/262 fleet road (even) fleet hampshire t/no. HP463772. 91 cranby street leicester t/no. LT44946. 16 chatham street leicester t/no. LT29268. Land and buildings on the south east side of chatham street and the north west side of york street leicester t/no. LT38753. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 17. Sept. 1996 Erworben am 27. Nov. 1997 Geliefert am 17. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £66,943,075 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Freehold properties:- (I) 42-46 upper parliament st,nottingham;t/no nt 134743; (ii) staveton house,east hampstead rd,wokingham; t/nos: sk 159854 and bk 222469; (iii) anchor mills,stockton st,hartlepool; t/no bm 202556; (iv) haybarn house,116-118 south st,dorking; t/no sy 419077; (v) alpha numeric house,72 furlong rd,bourne end; t/no bm 172657 and the l/hold property known as sword house,high wycombr; t/no bm 202556. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 17. Sept. 1996 Geliefert am 01. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from bourne end properties PLC and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of bourne end properties PLC to the chargee on any account whatsoever and in any manner whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the south side of drayton road shirley k/a drayton house drayton road shirley solihull west midlands t/n WK152502 and land and buildings k/a 148/152 west end lane and land to the rear of I52 west end lane hampstead t/n's LN238327,NGL167269,NGL167270,NGL158341,NGL458342,NGL328222 and NGL23135 and various other properties (see form 395) and by way of floating charge all the company's assets rights and revenues including uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1994 Geliefert am 20. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,523,100 and all other monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the "principal deeds" (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of collateral charge | Erstellt am 25. März 1994 Geliefert am 08. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from goldacre investments limited to the chargee under the terms of the principal deeds (as defined) and this collateral charge | |
Kurze Angaben Various l/hold and f/hold properties listed on form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 21. Dez. 1993 Geliefert am 08. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as dawnay day properties LTD.) and/or euroview investments limited under the terms of the principal deeds (as defined in the deed) | |
Kurze Angaben Various properties as specified. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Juni 1991 Geliefert am 04. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £12,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/Hold land at tollhouse hill, nottingham with buildings thereon known as city gate, tollhouse hill nottingham t/no nt 82283. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1991 Geliefert am 27. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Kurze Angaben Legal mortgage over f/hold chaucer house, isambard brunel road, portsmouth t/no. Hp 231553 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1991 Geliefert am 27. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5,150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Kurze Angaben F/Hold - chaucer house isambard brunel road portsmouth t/no hp 231553. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Dez. 1990 Geliefert am 17. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £4,300,000 and all other monies due or to become due from athe company to the chargee. Under the terms of this charge | |
Kurze Angaben F/H land abutting cumberland place, southampton together with buildings k/a grosvenor house, 18-20 cumberland place, southampton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Dez. 1990 Geliefert am 09. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £6,250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H land to the south east of rhodaus town, canterbury k/a clarkson house and land adjoining and land to the rear of 22 old dover road rhodaus town canterbury title nos K78007, k 593099, K359160, K71352 & k 596197. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Sept. 1990 Geliefert am 18. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the chargee. | |
Kurze Angaben F/Hold land abutting camden high street including 97 and 99 camden high street L.B. of camden t/no ngl 356660. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Juni 1990 Geliefert am 21. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further charge | Erstellt am 01. Juni 1990 Geliefert am 12. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the existing security (as defined) and this charge. | |
Kurze Angaben Properties as follows:- first freehold property known as drayton house drayton road shirley solihull-registered under title no sgl 218598. secondly leasehold premises known as 150 and 152 west end lane and land at rear of 152 west end lane hampstead london borough of camden registered under title no ngl 23135. thirdly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease date 15 1 1964 - registered under title no ln 238327. fourthly premises at the rear of 146 and 146A west end lane hampstead aforesaid. As comprised in a lease dated 3 10 1975 registered under title no ngl 458342 fifthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 1 11 1977 registered under title no ngl 458341. sixthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 18 6 1986 and made between the british railways board (1) malacarp terrazzo co LTD acting by the direction of j m iredale and s p l mahon (2) seventhly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 registered under title no ngl 167270 eighthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 - registered under title no ngl 167269. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Mai 1990 Geliefert am 18. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 97/99 camden high street camden, L.B. of camden t/no ngl 356660. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Juli 1989 Geliefert am 18. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from stencroft properties limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The workshop, 3 blackburn road, hampstead, l/b of camden including all buildings, fixtures (including trade) fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. März 1989 Geliefert am 05. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 104 west end lane hampstead. (Fixed charge only). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral charge | Erstellt am 29. Sept. 1988 Geliefert am 03. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,380,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of a legal charge dated 23/10/86 and this charge | |
Kurze Angaben Four head leases in respect of land & buildings lying to the east of west end lane hampstead title no: ngl 458342 ngl 458341, ln 238327 and two under leases title nos ngl 167269 and ngl 167270 (for details see form 395 and continuation sheet). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 1986 Geliefert am 27. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,380,000 | |
Kurze Angaben The properties specified on the form M395 title nos: sgl 218598 wk 152502; ngl 23135. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 1986 Geliefert am 25. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The properties specified on form M395 together with all fixed machinery buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878, together with all book and other debts in connection with the business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GOLDACRE (OFFICES) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0