ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02023193 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RANGENOW LIMITED | 28. Mai 1986 | 28. Mai 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. März 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Janine Butler als Direktor am 23. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Nigel Evans als Geschäftsführer am 23. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 256 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Michael Yorston als Direktor am 02. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diane Josephine Mcintyre als Geschäftsführer am 16. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| BUTLER, Janine | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 277534960001 | |||||||||
| YORSTON, Andrew Michael | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 257275320001 | |||||||||
| COTTLE, Paul | Sekretär | The Old Granary Brimpsfield GL4 8LD Gloucester | British | 77894160002 | ||||||||||
| EMETULU, Lola | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||||||
| HODGSON, Mark | Sekretär | 3 Cochran Close Churchdown GL3 2NA Gloucester Gloucestershire | British | 72699060001 | ||||||||||
| HOWIE, Philip Robert Sutherland | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 77939460004 | ||||||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Sekretär | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||||||
| WRIGHT, Garth Howard | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire England | British | 130769810001 | ||||||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 123612980001 | ||||||||||
| BAMFORD, Peter Richard | Geschäftsführer | Lantern House 4a Queens Gate Place SW7 5NT London | British | 54076100002 | ||||||||||
| BARR, Robert Nicolas | Geschäftsführer | Lindfield Faringdon Road OX14 1BD Abingdon Oxfordshire | Uk | British | 41968920003 | |||||||||
| BEST, Pauline Ann | Geschäftsführer | Honeysuckle Cottage Sutton Lane Sutton OX29 5RU Witney Oxfordshire | British | 68015830001 | ||||||||||
| BISWAS, Sumit Kumar | Geschäftsführer | 21 South Street OX2 0BE Oxford Oxfordshire | British | 63870460001 | ||||||||||
| BREWER, Stephen | Geschäftsführer | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Geschäftsführer | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||||||
| CHESWORTH, Paul | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||||||
| COTTLE, Paul | Geschäftsführer | The Old Granary Brimpsfield GL4 8LD Gloucester | British | 77894160002 | ||||||||||
| EDWARDS, Peter David | Geschäftsführer | Hockets Oriental Road SL5 7AZ Sunninghill Berkshire | British | 1908570001 | ||||||||||
| EVANS, David Nigel | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||||||
| EVANS, Mark | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||||||
| FREEMAN, William Ian Bede | Geschäftsführer | Herons Cottage Ferry Lane, Medmenham SL7 2EZ Marlow Buckinghamshire | England | British | 64442870001 | |||||||||
| GENT, Christopher Charles | Geschäftsführer | Crowshott Highclere RG20 9RY Newbury Berkshire | British | 50867930001 | ||||||||||
| GRAY, Ian | Geschäftsführer | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | 50246030004 | |||||||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Geschäftsführer | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||||||
| HARPER, Alan Paul | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 27272400002 | ||||||||||
| HEXT, Jane Helen | Geschäftsführer | 2 Saint Katherines Winterbourne Bassett SN4 9QG Swindon Wiltshire | England | British | 152305810001 | |||||||||
| HILLHOUSE, George Reid | Geschäftsführer | 12 Churchview Drive Barnwood GL4 7ES Gloucester Gloucestershire | British | 2899430001 | ||||||||||
| HODGSON, Mark | Geschäftsführer | 2 Alcotts Green Sandhurst GL2 9PE Gloucester Gloucestershire | British | 72699060002 | ||||||||||
| KEAYS, Helen Margaret | Geschäftsführer | Clematis Cottage Old Warwick Road Rowington CV35 7AA Warwick Warwickshire | British | 55393460002 | ||||||||||
| KEY, Matthew David | Geschäftsführer | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 62981720001 | ||||||||||
| LANGSTON, Edward | Geschäftsführer | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||||||
| LEE, Simon Christopher | Geschäftsführer | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||||||
| MAXWELL, Ian Ronald | Geschäftsführer | Coach House Adbury Park Adbury RG15 8HB Newbury Berkshire | British | 16186890001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Retail (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of rent deposit | Erstellt am 15. Juli 1996 Geliefert am 16. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15TH july 1996 | |
Kurze Angaben £10,868.75 or any increased sum payable into the deposit account in the name of the landlord at lloyds babk PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 08. Juli 1996 Geliefert am 19. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5,000 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of an underlease of even date | |
Kurze Angaben A rent deposit of £5,000 paid under a deed dated the 8/7/96. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 18. Aug. 1995 Geliefert am 05. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 12TH july 1995 and/or this deed | |
Kurze Angaben £11,163.50. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 05. Sept. 1994 Geliefert am 10. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company`s right title and interest in and to the subscriber base al book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 05. Sept. 1994 Geliefert am 07. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two agreements dated 28/93 and 3/2/93 and/or this charge | |
Kurze Angaben The interest of the company in its customers from time to time as well as after as before any receiver may be appointed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Sept. 1994 Geliefert am 07. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 06. Feb. 1991 Geliefert am 14. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements and/or this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 17. Nov. 1986 Geliefert am 26. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific charge over the benefit of all leasing rental hire purchase or credit sale agreements, all bills of exchange or promissory notes, all guarantees indemnities bonds or other securities. (For full details please see form 395 ref: M173/26NOV/ln). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. Okt. 1986 Geliefert am 22. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0