ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02023563 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row LS1 5AB Leeds England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CARE FOR LIFE (HOMES) LIMITED | 10. Juli 1986 | 10. Juli 1986 |
KERSLEYHEATH LIMITED | 28. Mai 1986 | 28. Mai 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Part Ground Floor & First Floor Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal Birmingham B45 9PZ zum C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB am 20. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patricia Lesley Lee als Geschäftsführer am 31. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Patricia Lesley Lee als Direktor am 22. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Albert Edward Smith als Geschäftsführer am 22. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katharine Kandelaki als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 30. Juni 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 28 Welbeck Street London W1G 8EW* am 06. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 23 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Perry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANSON, David Lindsay | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds C/O Pinsent Masons Llp England | United Kingdom | British | Director | 167628190001 | ||||
AMLANI, Pritesh | Sekretär | Birling Road Ryarsh ME19 5LS West Malling Ryarsh Oast House Kent United Kingdom | British | Company Secretary | 125206220002 | |||||
BLACKWELL, David John | Sekretär | 58 Bleadon Hill BS24 9JW Weston Super Mare Avon | British | Director | 37509410001 | |||||
HART, Thomas Richard | Sekretär | 7 Hookway Village EX17 3PU Crediton Devon | British | Solicitor | 60660270001 | |||||
KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel | Sekretär | Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor United Kingdom | 160356730001 | |||||||
LARKIN, Alexander Justin | Sekretär | Home Farm BS26 2QN Badgworth Somerset | British | Nursing Home Proprietor Manage | 154686420001 | |||||
LARKIN, Alexander Justin | Sekretär | 5 Brean Down Avenue BS23 4JH Weston Super Mare North Somerset | British | Nursing Home Proprietor Manage | 76000810003 | |||||
LARKIN, Kirsty Joanna | Sekretär | 5 Brean Down Avenue BS23 4JH Weston Super Mare North Somerset | British | 91536880001 | ||||||
MORRIS, Ralph Timothy | Sekretär | Warren Road TQ2 5TN Torquay Eden Roc Devon | British | Nursing Home Proprietor | 8478740002 | |||||
BLACKWELL, David John | Geschäftsführer | 58 Bleadon Hill BS24 9JW Weston Super Mare Avon | British | Director | 37509410001 | |||||
BOWERING, Roderick John Bertram, Dr | Geschäftsführer | 97 Church Road Worle BS22 9EA Weston Super Mare Avon | British | Medical Practitioner | 37509400001 | |||||
BOWERING, Roderick John Bertram, Dr | Geschäftsführer | 97 Church Road Worle BS22 9EA Weston Super Mare Avon | British | General Practitioner | 37509400001 | |||||
GARLAND, Moira Ann | Geschäftsführer | 41 Weston Hill Cottage Bristol Road Lower BS23 2PS Weston - Super - Mare Somerset | British | Director | 92921490002 | |||||
LARKIN, Alexander Justin | Geschäftsführer | Home Farm BS26 2QN Badgworth Somerset | England | British | Nursing Home Proprietor Manage | 154686420001 | ||||
LARKIN, Kirsty Joanna | Geschäftsführer | Home Farm BS26 2QN Badgworth Somerset | England | British | Nurse | 91536880002 | ||||
LEE, Patricia Lesley | Geschäftsführer | Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor | United Kingdom | British | Chief Executive | 192233540001 | ||||
MORRIS, Ralph Timothy | Geschäftsführer | 6 Wisteria Avenue Hutton BS24 9QF Weston Super Mare Avon | British | Director | 8478740001 | |||||
PERRY, David William | Geschäftsführer | Welbeck Street W1G 8EW London 28 | England | British | Director | 33988060002 | ||||
SMITH, Albert Edward | Geschäftsführer | Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor United Kingdom | England | British | Director | 77631340001 | ||||
TREON, Anoup | Geschäftsführer | Apt 1, Cambridge Gate Regents Park NW1 4JX London | United Kingdom | British | Director | 152212470001 | ||||
TREON, Jaynee Sunita | Geschäftsführer | Welbeck Street W1G 8EW London 28 | United Kingdom | British | Director | 42532090004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embrace Realty Scotland Limited | 06. Apr. 2016 | Parklands Rednal B45 9PZ Birmingham Two Parklands England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 25. März 2011 Geliefert am 06. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other member of the group to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 25. März 2011 Geliefert am 06. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from each other chargor and each other member of the group to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. März 2008 Geliefert am 02. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 2004 Geliefert am 22. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben St anthonys nursing home kew road weston super mare t/no ST145843. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 2004 Geliefert am 22. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben St anthonys court nursing home 26 lower bristol road weston super mare t/no AV118527. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 01. Aug. 2003 Geliefert am 07. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold being 1 kew rd,weston super mare,north somerset; t/no st 145843. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Mai 2001 Geliefert am 09. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Sept. 1986 Geliefert am 19. Sept. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 26 lower bristol road weston super mare avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ST. ANTHONY'S CARE HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0