NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED

NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02032186
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED25. Feb. 199925. Feb. 1999
    BELL CABLEMEDIA HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED01. Feb. 199501. Feb. 1995
    EAST LONDON TELECOMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED11. Juli 198611. Juli 1986
    HADDONCREST LIMITED27. Juni 198627. Juni 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 Seiten4.71

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF am 30. Sept. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Sept. 2015

    LRESSP

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 8,000,020
    SH01

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Beendigung der Bestellung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Geschäftsführer am 31. März 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor am 31. März 2014

    3 SeitenAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    22. Apr. 2014This document is a duplicate of the AP01 registered on 09/04/2014 for Mine Hifzi

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor am 31. März 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 20. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 8,000,020
    SH01

    Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor am 29. Nov. 2013

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Charles Gale als Geschäftsführer am 29. Nov. 2013

    1 SeitenTM01

    legacy

    97 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 31. Dez. 2012

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    Sekretär
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    151362620001
    DUNN, Robert Dominic
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    Geschäftsführer
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    Geschäftsführer
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    EnglandBritish182167230001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Sekretär
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    GILLIES, David
    Westfield
    High Street
    TN17 3EW Cranbrook
    Kent
    Sekretär
    Westfield
    High Street
    TN17 3EW Cranbrook
    Kent
    British72136060001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    RINGROSE, Edward Cameron
    98a Prince Of Wales Mansions
    Prince Of Wales Drive Battersea
    SW11 4BL London
    Sekretär
    98a Prince Of Wales Mansions
    Prince Of Wales Drive Battersea
    SW11 4BL London
    British36772480001
    STEELE, Elizabeth Meyer
    2241 Clermont Street
    Denver
    Colorado 80207
    Usa
    Sekretär
    2241 Clermont Street
    Denver
    Colorado 80207
    Usa
    Usa5074400001
    WOLFSOHN, Katherine Betty
    14 Ossington Street
    W2 4LZ London
    Sekretär
    14 Ossington Street
    W2 4LZ London
    British43666430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    ANDERSON, William David
    3 Fawcett Street
    SW10 9HN London
    Geschäftsführer
    3 Fawcett Street
    SW10 9HN London
    Canadian39821980002
    BATES, Alan Christopher
    Barnfield
    Fair Mile
    RG9 2JY Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Barnfield
    Fair Mile
    RG9 2JY Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish40253200001
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Geschäftsführer
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    BURNEY, Derek Hudson
    3442 Redpath Street
    H3G 2G3 Montreal
    Quebec
    Canada
    Geschäftsführer
    3442 Redpath Street
    H3G 2G3 Montreal
    Quebec
    Canada
    Canadian69018380002
    CANER, John Edward Zimmerman
    1930 Ellis Street
    FOREIGN San Francisco
    California 94115
    Usa
    Geschäftsführer
    1930 Ellis Street
    FOREIGN San Francisco
    California 94115
    Usa
    Us22349630001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CLARKE, Gregory Allison
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    British143319900001
    CLESHAM, Philip
    1 The Old House
    Horseshoe Lane
    GU6 8QL Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 The Old House
    Horseshoe Lane
    GU6 8QL Cranleigh
    Surrey
    British70777230001
    COYLE, Kevin Patrick
    3687 East Euclid Avenue
    FOREIGN Littleton
    Colorado 80121
    Usa
    Geschäftsführer
    3687 East Euclid Avenue
    FOREIGN Littleton
    Colorado 80121
    Usa
    Us22349620001
    DANIELS, Lyndon Ray
    8 South Point
    Orinda
    FOREIGN California 94563
    Usa
    Geschäftsführer
    8 South Point
    Orinda
    FOREIGN California 94563
    Usa
    Us25234540001
    DEW, Bryony
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    British70776760001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Geschäftsführer
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    GUNN, James Stewart
    4 Hurst Road
    BN6 9NJ Hassocks
    West Sussex
    Geschäftsführer
    4 Hurst Road
    BN6 9NJ Hassocks
    West Sussex
    British73656340001
    HARRIS, Michael John
    Appleford Meadows
    School Lane
    OX14 4NY Appleford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Appleford Meadows
    School Lane
    OX14 4NY Appleford
    Oxfordshire
    EnglandBritish174529110001
    HOWELL DAVIES, Peter David
    Wood End
    Beech Lane
    HP9 2SZ Jordans Village
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Wood End
    Beech Lane
    HP9 2SZ Jordans Village
    Buckinghamshire
    British74317800002
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    LABARGE, Charles
    4 Redpath Row
    Montreal
    Quebec H3g 1e5
    Canada
    Geschäftsführer
    4 Redpath Row
    Montreal
    Quebec H3g 1e5
    Canada
    Canadian32955350001
    LEVY, Yves Israel
    2 Rue Chevalier
    FOREIGN Moreney 95160
    France
    Geschäftsführer
    2 Rue Chevalier
    FOREIGN Moreney 95160
    France
    Italian22351080001
    LISOGURSKI, Michael
    426 Weldrick Road East
    Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    426 Weldrick Road East
    Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Canadian9765530001

    Hat NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 04. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 04. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charges all right, title and interest in: 1) the english charged land 2) the tangible moveable property 3) the accounts 4) the intellectual property 5) any goodwill 6) the investments 7) the shares and all dividends 8) all monetary claims by way of assignment all right, title and interest in: 1) any insurance policy 2) all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings 3) chattels hired, leased or rented 4) licences held. By way of floating charge the whole undertaking and assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as second security trustee for the secured parties (the "second security trustee")
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 03. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Second Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee")
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 23. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Security Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee") on the terms and conditions set out in the security trust agreement
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 03. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (as defined) or any of the other secured parties (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined) (including the debenture) and including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Lessor holdings charge
    Erstellt am 22. März 1996
    Geliefert am 11. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the operative documents
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all the shares togetehr with all dividends interest or other moneys paid or payable thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 22. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 22. März 1996
    Geliefert am 11. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the facility documents (as defined) and this charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge over all the shares to which the chargeor is now or may after the 22/3/96 become entitled together with all dividends nterest or other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 20. Mai 1994
    Geliefert am 08. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations due from the company to the chargee under the terms of the facility documents (as defined) and/or the deed (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed charge all shares,rights,moneys and securities. Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Trustee for Itself and for the Beneficiaries (As Defined)or Any of Them
    Transaktionen
    • 08. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Okt. 1988
    Geliefert am 03. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See form 395 M66 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Jones Intercable Inc
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 12. Aug. 1986
    Geliefert am 19. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to robert fleming & co limited as agent for itself and the banks (defied) or any of them under or pursuant to aloan agreement of even date.
    Kurze Angaben
    Right title and interest to all monies payable by the guarantor to the account of the company under an agreement dated 12TH august, 1986.
    Berechtigte Personen
    • Robert Fleming & Co Limited
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NTL HOLDINGS (EAST LONDON) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Sept. 2016Aufgelöst am
    09. Sept. 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0