THORNE POULTRY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THORNE POULTRY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02035669 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THORNE POULTRY LIMITED?
- Herstellung von Fleisch- und Geflügelfleischprodukten (10130) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich THORNE POULTRY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BDO LLP 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THORNE POULTRY LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2014 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2015 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für THORNE POULTRY LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Nov. 2016 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Dez. 2016 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für THORNE POULTRY LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für THORNE POULTRY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in freiwilliger Mitgliederliquidation | 3 Seiten | REST-MVL | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Mai 2016 | 24 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 24 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Apr. 2016 | 20 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5Th Floor 6 St. Andrew Street London England and Wales EC4A 3AE zum C/O Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU am 06. Mai 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Verschiedenes Section 519 companies act 2006 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Feb. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 15 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Miller als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Leon Barry Abbitt als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Steven als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Louis Vernaus als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Maarten Kusters als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THORNE POULTRY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Sekretär | Floor 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| ABBITT, Leon Barry | Geschäftsführer | Stadium Way Eurolink Business Park ME10 3SP Sittingbourne Syndale Court Kent United Kingdom | England | British | 153119640001 | |||||||||
| ROXBURGH, Roy | Sekretär | 515 North Deeside Road Cults AB15 9ES Aberdeen Aberdeenshire | British | 194640001 | ||||||||||
| IAIN SMITH AND COMPANY | Sekretär | 18-20 Queen's Road AB15 4ZT Aberdeen Grampian | 93547510001 | |||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Sekretär | 66 Queen's Road AB15 4YE Aberdeen | 119967690001 | |||||||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
| CHRISTIAANSE, Anthony Martin | Geschäftsführer | 3065 Sc Rotterdam 's-Gravenweg 551 The Netherlands | Dutch | 129239540002 | ||||||||||
| DUNCAN, Alfred John | Geschäftsführer | Saetra House Inchmarlo Road AB31 3RR Banchory Aberdeenshire | United Kingdom | British | 402690001 | |||||||||
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Geschäftsführer | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 | England | British | 105961550001 | |||||||||
| FYFE, Archibald | Geschäftsführer | 14 Cloverfield Place Bucksburn AB2 9RH Aberdeen Aberdeenshire | British | 957330001 | ||||||||||
| IMRAY, Iain Murray | Geschäftsführer | 41 Hammersmith Road AB10 6NA Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 63444910001 | |||||||||
| KUSTERS, Maarten | Geschäftsführer | Floor 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th United Kingdom | Belgium | Dutch | 167543410001 | |||||||||
| LAMMERS, Antonius Matheus Maria | Geschäftsführer | 7005-7023 5692 Hb Son En Breugel Ekkersrijt The Netherlands | Dutch | 126350570004 | ||||||||||
| MILLER, Peter John | Geschäftsführer | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | United Kingdom | British | 55542610002 | |||||||||
| PARIS, Walter Walker | Geschäftsführer | 21 Hillview Road AB31 4EG Banchory Kincardineshire Scotland | British | 338220001 | ||||||||||
| SALKELD, David John | Geschäftsführer | The Old Hall Back Lane Bramham LS23 6QR Wetherby West Yorkshire | England | British | 111995510001 | |||||||||
| SIMS, David John | Geschäftsführer | Beech House Main Street Scarrington NG13 9BQ Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 52926050001 | |||||||||
| STEPHEN, Andrew Michael Duthie | Geschäftsführer | Speymuir 3 Victoria Street AB53 4RE Turriff Aberdeenshire Scotland | Scotland | British | 338210001 | |||||||||
| STEVEN, Mark Alexander | Geschäftsführer | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | Scotland | British | 159788300001 | |||||||||
| VERNAUS, Louis Antoine Maria | Geschäftsführer | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | Netherlands | Dutch | 146206430001 |
Hat THORNE POULTRY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second ranking security agreement (assignment of receivables) | Erstellt am 02. Okt. 2012 Geliefert am 15. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any subordinated secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First ranking security agreement (assignment of receivables) | Erstellt am 02. Okt. 2012 Geliefert am 15. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any senior secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An intercreditor and security agreement | Erstellt am 30. Mai 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the dep. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Mai 2007 Geliefert am 08. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 23. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the guarantee including in particular all monies due by the trustees (as defined) under or in connection with any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 14. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 1995 Geliefert am 04. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Aug. 1992 Geliefert am 21. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) or the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the agreement or the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben Property in thorne,south yorkshire.t/nofor full details please see doc M24C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Aug. 1992 Geliefert am 21. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) or the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the agreement or the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben Property in thorne,south yorkshire.t/no.for full details please see doc M23C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Okt. 1990 Geliefert am 24. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Okt. 1990 Geliefert am 23. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the agreement dated 5.10.90 and the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben Property in thorne, south yorkshire. Title no. Syk 243859. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental agreement to a chattel mortgage dtd 26.1.88 | Erstellt am 01. Aug. 1988 Geliefert am 02. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a chattel mortgage dated 26.1.1988 | |
Kurze Angaben 1 x primary air chiller supplied by pennine indentity number 210-214 see form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Apr. 1988 Geliefert am 06. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to an agreement dated 11.1.88 | |
Kurze Angaben 178 franking machine cost-£1,062 supplier-pirney bowes (please see form 395 & schedule for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 26. Jan. 1988 Geliefert am 28. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben Two cochran wee chieftain bailers identity no's-160 & 161 one stork dry offal systems identity nos 012, 014, 020, 021/022, 026, 027, 028, 029, 030, 031 044, 053-057, 059-064, 074-077 (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Sept. 1987 Geliefert am 16. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat THORNE POULTRY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0