COFFEE POINT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COFFEE POINT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02037135 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COFFEE POINT LIMITED?
- Sonstige Verpflegungsdienste (56290) / Gastgewerbe
Wo befindet sich COFFEE POINT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | East Wing 14th Floor 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COFFEE POINT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CRAYGLOW LIMITED | 15. Juli 1986 | 15. Juli 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COFFEE POINT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für COFFEE POINT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für COFFEE POINT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Kris Paul Ludo Geysels als Direktor am 18. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Mackie als Geschäftsführer am 18. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Daniel Henry Abrahams als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Willis als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Brian Mackie am 01. Mai 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von War Tin als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von War Tin als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 5 Seiten | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 4 Seiten | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Apr. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs War War Tin als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Greenwood als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Helen Margaret Willis als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COFFEE POINT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAMS, Daniel Henry | Geschäftsführer | 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick East Wing 14th Floor London | England | British | 183822370001 | |||||
| GEYSELS, Kris Paul Ludo | Geschäftsführer | 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick East Wing 14th Floor London | Belgium | Belgian | 193655140001 | |||||
| COOK, Josephine Isabel | Sekretär | White House Clinton Lane TN8 7PP Bough Beech | British | 66475960002 | ||||||
| GREENWOOD, Michael Frank | Sekretär | 389 Chiswick High Road Chiswick W4 4AJ London East Wing 14th Floor England | British | 163171710001 | ||||||
| HUSSEY, Paul Nicholas | Sekretär | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc | British | 28010290009 | ||||||
| TIN, War War | Sekretär | 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick East Wing 14th Floor London | 174470180001 | |||||||
| BROTHERWOOD, Tony James | Geschäftsführer | 54 Frampton Grove Westcroft Park MK4 4GE Milton Keynes | England | British | 143546010001 | |||||
| CUNNINGHAM, James Alan | Geschäftsführer | 115 Broomwood Road SW11 6JU London | England | British | 51864840002 | |||||
| DEMBITZ, John Andrew | Geschäftsführer | 10 Crescent Road SW20 8EX London | British | 15837270001 | ||||||
| DEMBITZ, John Andrew | Geschäftsführer | 10 Crescent Road SW20 8EX London | British | 15837270001 | ||||||
| DOBBS, Neil Stoker | Geschäftsführer | 17 Elvaston Place SW7 5QF London | United Kingdom | British | 20511010001 | |||||
| DRYSDALE, Harold Bruce | Geschäftsführer | 6 Windsor Park NE28 8UQ Wallsend Tyne & Wear | British | 111822640001 | ||||||
| DRYSDALE, Harold Bruce | Geschäftsführer | Field House Eachwick NE18 0AY Newcastle | United Kingdom | British | 106272340001 | |||||
| HUGHES, Leonard | Geschäftsführer | 50 St Margarets Street ME1 1TU Rochester Kent | British | 52234370002 | ||||||
| HUSSEY, Paul Nicholas | Geschäftsführer | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc | England | British | 28010290009 | |||||
| LEWIS, Gary Kenneth | Geschäftsführer | 89 Lukins Drive CM6 1XQ Dunmow Essex | United Kingdom | British | 65266510002 | |||||
| MACKIE, Brian | Geschäftsführer | 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick East Wing 14th Floor London | Scotland | British | 173446760002 | |||||
| MOONEY, Andrew John | Geschäftsführer | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 34345860002 | |||||
| MURRELL, Andrew John | Geschäftsführer | 5 Wood Ride BR5 1PZ Petts Wood Kent | England | British | 114514100001 | |||||
| NAISMITH, Nicholas John Ewen | Geschäftsführer | Grants Grants Lane RH8 0RQ Limpsfield Surrey | British | 2892470011 | ||||||
| NEWBERRY, Charles Timothy | Geschäftsführer | 56 Streathbourne Road SW17 8QX London | England | English | 29754260005 | |||||
| PRATT, Isabelle | Geschäftsführer | 1 Vicarage Close Colgate RH12 4BB Horsham West Sussex | French | 103007770001 | ||||||
| PRATT, Isabelle | Geschäftsführer | 1 Vicarage Close Colgate RH12 4BB Horsham West Sussex | French | 103007770001 | ||||||
| ROE, Timothy Michael | Geschäftsführer | 389 Chiswick High Road Chiswick W4 4AJ London East Wing 14th Floor England | England | British | 51264250001 | |||||
| STRINGFELLOW, Robin John | Geschäftsführer | 23a The Street Corton NR32 5HW Lowestoft Suffolk | British | 113787560001 | ||||||
| THOMPSON, Peter Charles Fenton | Geschäftsführer | Long Dawkhams Station Road Woldingham CR3 7DE Caterham Surrey | British | 19655110001 | ||||||
| THOMPSON, Peter Charles Fenton | Geschäftsführer | Long Dawkhams Station Road Woldingham CR3 7DE Caterham Surrey | British | 19655110001 | ||||||
| TRACE, Charles Lawrence | Geschäftsführer | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | England | British | 129244340001 | |||||
| TRACE, Charles Lawrence | Geschäftsführer | Sands Lane Small Dole BN5 9YL Henfield Ashleigh House West Sussex | England | British | 129244340001 | |||||
| WHITELING, Mark Argent | Geschäftsführer | 389 Chiswick High Road Chiswick W4 4AJ London East Wing 14th Floor England | England | British | 101297630001 | |||||
| WILLIS, Helen Margaret | Geschäftsführer | 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick East Wing 14th Floor London | United Kingdom | British | 277089380001 |
Hat COFFEE POINT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Master assignment | Erstellt am 16. Nov. 2005 Geliefert am 29. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies due and the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities in connection with the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 05. März 2004 Geliefert am 12. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The shares and security assets and includes any proceeds of sale or other realisation thereof or any part thereof, shares 14,940 ordinary shares in the share capital of sk automatics limited (no. 1394004). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 11. Feb. 2003 Geliefert am 19. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and security assets and any proceeds of sale or other realisation thereof and all stocks,securities,rights,money or other property and bonus,dividend and interest accruing thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Feb. 2003 Geliefert am 14. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 11. Feb. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Jan. 2002 Geliefert am 08. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge supplemental to a debenture dated 24 june 1991 issued by the company | Erstellt am 26. Juni 2000 Geliefert am 30. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 4 may 1995 between confidential invoice discounting limited and the company and any deed amending or replacing the same (all such deeds being hereinafter called the charged deeds) and all book debts and other debts the subject of the charged deeds as and when the same shall become due or owing to the company upon re-vesting in the company whether pursuant to the charged deeds or otherwise. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Sept. 1999 Geliefert am 30. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 1991 Geliefert am 03. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 10. Nov. 1988 Geliefert am 17. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat COFFEE POINT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0