COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED

COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02047059
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    P O Box 55
    1 Surrey Street
    WC2R 2NT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEGIBUS 755 LIMITED15. Aug. 198615. Aug. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 1999

    Welche sind die letzten Einreichungen für COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Umregistrierung

    RES02

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    2 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 1999

    6 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363a

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    legacy

    1 Seiten652C

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 1998

    6 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 1997

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Sonderbeschluss

    SRES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 1996

    7 SeitenAA

    legacy

    9 Seiten363a

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 1995

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SANDLAND, Alan Wallace
    50 Hill Turrets Close
    S11 9RE Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    50 Hill Turrets Close
    S11 9RE Sheffield
    South Yorkshire
    British871130001
    BEECH, Walter
    Water Wheel View
    45 Main Street North Anston
    S31 7BD Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Water Wheel View
    45 Main Street North Anston
    S31 7BD Sheffield
    South Yorkshire
    British32380510001
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish16220320001
    DODD, Alan
    Roan House Crabnook Lane
    Farnsfield
    NG22 8JY Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Roan House Crabnook Lane
    Farnsfield
    NG22 8JY Newark
    Nottinghamshire
    British871160001
    DOWNTON, Christopher Hurst
    Sutton House High Street
    DN10 4RF Gringley On The Hill
    Geschäftsführer
    Sutton House High Street
    DN10 4RF Gringley On The Hill
    British55643940001

    Hat COAL CONTRACTORS (U.K.) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 10. Juni 1994
    Geliefert am 28. Juni 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as trustee for the secured creditors (as defined for securing the liabilities (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 25. Sept. 1989
    Geliefert am 06. Okt. 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    Supplemental security agreement
    Erstellt am 30. Mai 1989
    Geliefert am 19. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from company and/or all or any or the other companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land at fenwicks close farm,backworth,newcastle upon tyne,.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC.as Trustee for the Secured Creditors.
    Transaktionen
    • 19. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    Security agreement.
    Erstellt am 08. Apr. 1988
    Geliefert am 22. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due on to become due from the company, nsm PLC, hallam overseas limited, the minning investment corporation limited, any "charging company" (as defined in the security agreement) the ship owning company (as likewise defined) or mincorp shipping & finance limited to barclays bank PLC or any other secured creditor (as likewise defined) under any financing dowment (as likewise defined)
    Kurze Angaben
    Patents, registered designs or copyrights etc. the defined properties in backworth; cossall; evenwood; leasingthorne and lynesack. (Please refer to form M395 and attached continuation shets thereto for full particulars of all property charged ref- m 237). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Mai 1987
    Geliefert am 03. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £120,000
    Kurze Angaben
    F/Hold land at evenwood, durham.
    Berechtigte Personen
    • J.E.Wright
    Transaktionen
    • 03. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 24. Dez. 1986
    Geliefert am 03. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £265,650 and all other monies due on to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Equipment as listed on form 395 relevant. To this charge.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited.
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1986
    Geliefert am 24. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    One-used aveling barford green, serial no sgc 1793, one-used reedmill sk 25 drill rk serial no 1060178.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Chattels mortgage.
    Erstellt am 24. Nov. 1986
    Geliefert am 24. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Three-used lim a 2.400 b draglines serial no's 3633-2/3685/11 and 712-a-128.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Chattels mortgage.
    Erstellt am 24. Nov. 1986
    Geliefert am 24. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Three-used ruston bucyrus 150 draglines serial no's 22951-23239 and 22685.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 12. Nov. 1986
    Geliefert am 01. Dez. 1986
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1986Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0