HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED

HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02049088
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Fifth Floor
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    8 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mark Moran als Geschäftsführer am 01. März 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 05. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jason David Lock als Geschäftsführer am 01. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Moran als Direktor am 01. Apr. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 02. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 21 Exhibition House Addison Bridge Place London W14 8XP England* am 23. Juli 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Priory House, Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TP* am 04. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschlüsse

    Conflict of int 22/12/2010
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HALL, David James
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Sekretär
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    British132246660001
    HALL, David James
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Geschäftsführer
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    EnglandBritish132246660001
    GREENSMITH, Paul John
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    British150227000001
    HATHER, Jon
    83 High Street
    BR6 7BB Farnborough Village
    Kent
    Sekretär
    83 High Street
    BR6 7BB Farnborough Village
    Kent
    British68848420001
    KELSHAW, Sonia
    Spring Valley
    Horrocks Road Turton Edgworth
    BL7 0QT Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    Spring Valley
    Horrocks Road Turton Edgworth
    BL7 0QT Bolton
    Lancashire
    British7254900001
    MUKERJI, Swagatam
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British121222440001
    O'CONNELL, Kevin Daniel
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    Sekretär
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    English15336730002
    PAYNE, Keith
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    British65484490001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Sekretär
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    British58759290001
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Sekretär
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    British110080200001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Sekretär
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    British73750450005
    BRADFORD, Martin Major, Mr.
    10 Edenhurst Avenue
    SW6 3PB London
    Geschäftsführer
    10 Edenhurst Avenue
    SW6 3PB London
    EnglandBritish9565360001
    BRADSHAW, Stephen Wallace
    Great Elm
    BA11 3NY Nr Frome
    Glenthorpe
    Somerset
    Geschäftsführer
    Great Elm
    BA11 3NY Nr Frome
    Glenthorpe
    Somerset
    EnglandBritish132026810001
    CARTER, Patrick Robert, Lord
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    Geschäftsführer
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    United KingdomBritish6338850001
    CRAIG, Karen Andrea
    17 Ashmount Road
    N19 3BJ London
    Geschäftsführer
    17 Ashmount Road
    N19 3BJ London
    British43563430001
    EASTERMAN, Philip Harry
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    British63476990001
    GREENSMITH, Paul John
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish150227000001
    HAMMONDS, Geoffrey, Dr
    7 Greenthorne Close
    Edgworth
    BL7 0BL Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Greenthorne Close
    Edgworth
    BL7 0BL Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish45948680001
    HEYWOOD, Anthony George
    Yamas House
    Chiddingly Road
    TN21 0LJ Horam
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Yamas House
    Chiddingly Road
    TN21 0LJ Horam
    East Sussex
    British30119220003
    KELSHAW, Malcolm Anthony
    Spring Valley Horrocks Road Edgworth
    Turton
    BL7 0QT Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Spring Valley Horrocks Road Edgworth
    Turton
    BL7 0QT Bolton
    Lancashire
    British15279250001
    KELSHAW, Sonia
    Spring Valley
    Horrocks Road Turton Edgworth
    BL7 0QT Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Spring Valley
    Horrocks Road Turton Edgworth
    BL7 0QT Bolton
    Lancashire
    British7254900001
    LOCK, Jason David
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Geschäftsführer
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    EnglandBritish144822040001
    MACK, Torsten
    Apartment 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    Geschäftsführer
    Apartment 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    British93474760002
    MORAN, Mark
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    Geschäftsführer
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    United KingdomBritish60066000008
    PATEL, Chaitanya Bhupendra
    Robin Hill
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Robin Hill
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritish63915280004
    PHIPPEN, Kent William
    35 Singleton Scarp
    Woodside Park
    N12 7AR London
    Geschäftsführer
    35 Singleton Scarp
    Woodside Park
    N12 7AR London
    American36778230001
    PRIESTLEY, Nicholas, Dr
    14 Woodlea
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    Geschäftsführer
    14 Woodlea
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    British45948880001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Geschäftsführer
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    EnglandBritish58759290001
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Geschäftsführer
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    EnglandBritish110080200001
    STEWART, Serena Jane
    23 Lindsey Street
    CM16 6RB Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    23 Lindsey Street
    CM16 6RB Epping
    Essex
    British57758710001
    THODY, Norman Carl
    2 Capenors
    Hammonds Ridge
    RH15 9QL Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    2 Capenors
    Hammonds Ridge
    RH15 9QL Burgess Hill
    West Sussex
    British41290780001
    THOMPSON, Christopher, Professor
    3 Preshaw House
    Preshaw
    SO32 1HP Upham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    3 Preshaw House
    Preshaw
    SO32 1HP Upham
    Hampshire
    United KingdomBritish162000490001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritish73750450005

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Priory Securitisation Limited
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    06. Apr. 2016
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer3982134
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 09. Nov. 2005
    Geliefert am 22. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being bristol grange heath house lane off bell road bristol, fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (Facility Agent)
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Sept. 2005
    Geliefert am 26. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a priory hospital altrincham rappax road altrincham cheshire t/no GM32147, priory hospital bristol heath house lane off bell hill bristol t/no AV204454, f/h property k/a priory grange heath house lane purdown bristol t/no AV247767. For details of further properties charge please refer to form 395. all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery and floating charge all assets no effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 4 september 2003 and
    Erstellt am 15. Jan. 2004
    Geliefert am 26. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (whether for its own account or as trustee for the borrower secured creditors) or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Citicorp Trustee Company Limited (The "Borrower Security Trustee") as Security Trustee for Theborrower Secured Creditors and the Capex Facility Secured Creditors
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment and restatement deed
    Erstellt am 19. Sept. 2003
    Geliefert am 09. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the other obligors or the issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All shares held in the future and in relation to such shares; all dividends, interest and other monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Priory Securitisation Holdings Limited (The "Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Borrower debenture
    Erstellt am 04. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The aggregate of all obligations moneys and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the english real property, the tangible moveable property, the obligor accounts; the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security accession deed (the "security accession deed") made by the acceding charging company in favour of the royal bank of scotland PLC as trustee for the secured parties (the "trustee") in relation to a debenture (the "debenture") dated 10 june 2002 made by priory healthcare acquisition co. Limited in favour of the trustee
    Erstellt am 10. Juni 2002
    Geliefert am 17. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All financial obligations at any time due, owing or incurred by priory healthcare acquisition co. Limited or any borrower or any guarantor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the charging company's right, title and interest from time to time in and to the real property; the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property and goodwill, the investments, the shares, all dividends, by way of first floating charge the whole of the acceding charging company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Trustee, Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Trustee or as an Additional Trustee
    Transaktionen
    • 17. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 1987
    Geliefert am 14. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from malcolm anthony kelshaw and/or sonia elizabeth kelshaw to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Highbank private hospital, walshaw road bury lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 1987
    Geliefert am 16. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0