HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02049088 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Fifth Floor 80 Hammersmith Road W14 8UD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Moran als Geschäftsführer am 01. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jason David Lock als Geschäftsführer am 01. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Moran als Direktor am 01. Apr. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 21 Exhibition House Addison Bridge Place London W14 8XP England* am 23. Juli 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Priory House, Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TP* am 04. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL, David James | Sekretär | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | British | 132246660001 | ||||||
| HALL, David James | Geschäftsführer | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | 132246660001 | |||||
| GREENSMITH, Paul John | Sekretär | 8 Ennerdale Road Kew TW9 3PG Richmond Upon Thames Surrey | British | 150227000001 | ||||||
| HATHER, Jon | Sekretär | 83 High Street BR6 7BB Farnborough Village Kent | British | 68848420001 | ||||||
| KELSHAW, Sonia | Sekretär | Spring Valley Horrocks Road Turton Edgworth BL7 0QT Bolton Lancashire | British | 7254900001 | ||||||
| MUKERJI, Swagatam | Sekretär | The Peacocks Drews Park, Knotty Green HP9 2TT Beaconsfield Buckinghamshire | British | 121222440001 | ||||||
| O'CONNELL, Kevin Daniel | Sekretär | 27 Stag Green Avenue AL9 5EB Hatfield Hertfordshire | English | 15336730002 | ||||||
| PAYNE, Keith | Sekretär | 90 Long Plough Aston Clinton HP22 5HD Aylesbury Buckinghamshire | British | 65484490001 | ||||||
| PURSE, Stephen John | Sekretär | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | British | 58759290001 | ||||||
| SPRUZEN, David Andrew | Sekretär | Homewood The Avenue, Farnham Common SL2 3JY Slough Bucks | British | 110080200001 | ||||||
| WEIGHT, James Dominic | Sekretär | 11 Courtney Place KT11 2BE Cobham Surrey | British | 73750450005 | ||||||
| BRADFORD, Martin Major, Mr. | Geschäftsführer | 10 Edenhurst Avenue SW6 3PB London | England | British | 9565360001 | |||||
| BRADSHAW, Stephen Wallace | Geschäftsführer | Great Elm BA11 3NY Nr Frome Glenthorpe Somerset | England | British | 132026810001 | |||||
| CARTER, Patrick Robert, Lord | Geschäftsführer | 60 Hamilton Park West N5 1AB London | United Kingdom | British | 6338850001 | |||||
| CRAIG, Karen Andrea | Geschäftsführer | 17 Ashmount Road N19 3BJ London | British | 43563430001 | ||||||
| EASTERMAN, Philip Harry | Geschäftsführer | 3 Oakview Hyde Heath HP6 5SE Amersham Buckinghamshire | British | 63476990001 | ||||||
| GREENSMITH, Paul John | Geschäftsführer | 8 Ennerdale Road Kew TW9 3PG Richmond Upon Thames Surrey | England | British | 150227000001 | |||||
| HAMMONDS, Geoffrey, Dr | Geschäftsführer | 7 Greenthorne Close Edgworth BL7 0BL Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 45948680001 | |||||
| HEYWOOD, Anthony George | Geschäftsführer | Yamas House Chiddingly Road TN21 0LJ Horam East Sussex | British | 30119220003 | ||||||
| KELSHAW, Malcolm Anthony | Geschäftsführer | Spring Valley Horrocks Road Edgworth Turton BL7 0QT Bolton Lancashire | British | 15279250001 | ||||||
| KELSHAW, Sonia | Geschäftsführer | Spring Valley Horrocks Road Turton Edgworth BL7 0QT Bolton Lancashire | British | 7254900001 | ||||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | 144822040001 | |||||
| MACK, Torsten | Geschäftsführer | Apartment 23 Park House 16 Northfields SW18 1DD London | British | 93474760002 | ||||||
| MORAN, Mark | Geschäftsführer | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor | United Kingdom | British | 60066000008 | |||||
| PATEL, Chaitanya Bhupendra | Geschäftsführer | Robin Hill Warren Lane KT22 0ST Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 63915280004 | |||||
| PHIPPEN, Kent William | Geschäftsführer | 35 Singleton Scarp Woodside Park N12 7AR London | American | 36778230001 | ||||||
| PRIESTLEY, Nicholas, Dr | Geschäftsführer | 14 Woodlea Worsley M28 2QJ Manchester | British | 45948880001 | ||||||
| PURSE, Stephen John | Geschäftsführer | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | England | British | 58759290001 | |||||
| SPRUZEN, David Andrew | Geschäftsführer | Homewood The Avenue, Farnham Common SL2 3JY Slough Bucks | England | British | 110080200001 | |||||
| STEWART, Serena Jane | Geschäftsführer | 23 Lindsey Street CM16 6RB Epping Essex | British | 57758710001 | ||||||
| THODY, Norman Carl | Geschäftsführer | 2 Capenors Hammonds Ridge RH15 9QL Burgess Hill West Sussex | British | 41290780001 | ||||||
| THOMPSON, Christopher, Professor | Geschäftsführer | 3 Preshaw House Preshaw SO32 1HP Upham Hampshire | United Kingdom | British | 162000490001 | |||||
| WEIGHT, James Dominic | Geschäftsführer | 11 Courtney Place KT11 2BE Cobham Surrey | England | British | 73750450005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priory Securitisation Limited | 06. Apr. 2016 | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HIGHBANK PRIVATE HOSPITAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 09. Nov. 2005 Geliefert am 22. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property being bristol grange heath house lane off bell road bristol, fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 15. Sept. 2005 Geliefert am 26. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a priory hospital altrincham rappax road altrincham cheshire t/no GM32147, priory hospital bristol heath house lane off bell hill bristol t/no AV204454, f/h property k/a priory grange heath house lane purdown bristol t/no AV247767. For details of further properties charge please refer to form 395. all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery and floating charge all assets no effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 4 september 2003 and | Erstellt am 15. Jan. 2004 Geliefert am 26. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee (whether for its own account or as trustee for the borrower secured creditors) or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendment and restatement deed | Erstellt am 19. Sept. 2003 Geliefert am 09. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the other obligors or the issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All shares held in the future and in relation to such shares; all dividends, interest and other monies payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Borrower debenture | Erstellt am 04. Sept. 2003 Geliefert am 23. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The aggregate of all obligations moneys and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all right title and interest in and to the english real property, the tangible moveable property, the obligor accounts; the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security accession deed (the "security accession deed") made by the acceding charging company in favour of the royal bank of scotland PLC as trustee for the secured parties (the "trustee") in relation to a debenture (the "debenture") dated 10 june 2002 made by priory healthcare acquisition co. Limited in favour of the trustee | Erstellt am 10. Juni 2002 Geliefert am 17. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All financial obligations at any time due, owing or incurred by priory healthcare acquisition co. Limited or any borrower or any guarantor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the charging company's right, title and interest from time to time in and to the real property; the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property and goodwill, the investments, the shares, all dividends, by way of first floating charge the whole of the acceding charging company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1987 Geliefert am 14. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from malcolm anthony kelshaw and/or sonia elizabeth kelshaw to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Highbank private hospital, walshaw road bury lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 1987 Geliefert am 16. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0