RIG 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RIG 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02051243 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RIG 2 LIMITED?
- Fotografische Tätigkeiten n.a. (74209) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich RIG 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 10 Pittbrook Street Manchester M12 6JX |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RIG 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| REFINERY PHOTOGRAPHIC LIMITED | 27. Sept. 2001 | 27. Sept. 2001 |
| MONTAGE ASSOCIATES LIMITED | 29. Okt. 1991 | 29. Okt. 1991 |
| MONTAGE PHOTOGRAPHIC STUDIOS LIMITED | 06. Apr. 1990 | 06. Apr. 1990 |
| MONTAGE PHOTOGRAPHY LIMITED | 01. Sept. 1986 | 01. Sept. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIG 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RIG 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 26. Juni 2015 | 17 Seiten | RP04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed refinery photographic LIMITED\certificate issued on 08/10/12 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Caddick als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RIG 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWERS, Colin | Sekretär | 49 Bryn Lea Terrace Barrow Bridge BL1 7NB Bolton Lancashire | British | 72062820002 | ||||||
| BOWERS, Colin | Geschäftsführer | 49 Bryn Lea Terrace Barrow Bridge BL1 7NB Bolton Lancashire | England | British | 72062820002 | |||||
| LAFFAN, Martin | Geschäftsführer | 83 Northenden Road M33 2ED Sale Cheshire | United Kingdom | British | 17810460003 | |||||
| PAPWORTH, Nigel | Geschäftsführer | 53 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Cheadle Cheshire | England | British | 61570140002 | |||||
| CHAPMAN, David George | Sekretär | Sandhurst Sandy Lane Goostrey CW4 8NT Crewe Cheshire | British | 6100020001 | ||||||
| COLE, Peter Reginald Urquhart | Sekretär | 4 Derwent Close SK13 8RH Glossop Derbyshire | British | 2218460001 | ||||||
| BARNES, Barry Arthur | Geschäftsführer | 10 Claremont Range Gorton M18 7LT Manchester Lancashire | British | 31505370001 | ||||||
| CADDICK, Patrick Crichton | Geschäftsführer | Hawkridge Drive Northern Moor M230GG Manchester 21 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 152257580001 | |||||
| CHAPMAN, David George | Geschäftsführer | Sandhurst Sandy Lane Goostrey CW4 8NT Crewe Cheshire | British | 6100020001 | ||||||
| CHAPMAN, David George | Geschäftsführer | Sandhurst Sandy Lane Goostrey CW4 8NT Crewe Cheshire | British | 6100020001 | ||||||
| CLEGG, Ian Kenneth | Geschäftsführer | Greenmount Close Greenmount BL8 4HN Bury 5 Lancashire United Kingdom | British | 71567160004 | ||||||
| COLE, Peter Reginald Urquhart | Geschäftsführer | 4 Derwent Close SK13 8RH Glossop Derbyshire | British | 2218460001 | ||||||
| HARDICRE, Colin | Geschäftsführer | 7 Parkfield Lodge Parkfield Road South M20 6DD Manchester | England | British | 41444420001 | |||||
| WILD, John | Geschäftsführer | 54 Fairlands Road BL9 6QB Bury Lancashire | British | 71567000001 |
Hat RIG 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 19. März 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 19. März 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 19. März 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 19. März 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 18. März 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 02. Juli 1987 Geliefert am 10. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Okt. 1986 Geliefert am 04. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0