WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02058427
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WATERFORD WEDGWOOD HOLDINGS PLC 21. Okt. 198621. Okt. 1986
    DAYOFFER PUBLIC LIMITED COMPANY 25. Sept. 198625. Sept. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2009
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2009
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    38 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Mai 2016

    46 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2015

    57 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2014

    62 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2013

    58 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:order of court removing angus matthew martin as liquidator of the company
    9 SeitenLIQ MISC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Mai 2012

    46 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:form 2.39B notice of vacation of office
    15 SeitenLIQ MISC

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    26 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Jan. 2011

    50 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Juli 2010

    54 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Jan. 2010

    27 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Jan. 2010

    2 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Jan. 2010

    49 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    legacy

    3 SeitenMG02

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Juli 2009

    59 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Juli 2009

    30 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOWLING, Patrick John
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Sekretär
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Irish29859260001
    DOWNIE, Mark Lindsay
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    Sekretär
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    British128949130001
    JENNINGS, Wendy Joy
    189 Aston Village
    Pipe Gate
    TF9 4JF Market Drayton
    Shropshire
    Sekretär
    189 Aston Village
    Pipe Gate
    TF9 4JF Market Drayton
    Shropshire
    British8248520001
    STONIER, George
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    British8248550001
    ASHWELL, Kneale Holland
    6 Clarence Crescent
    SL4 5DT Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    6 Clarence Crescent
    SL4 5DT Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish52176650002
    BARNES, Richard Anthony
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritish9859220001
    BRENNAN, Donald P
    Hoaglands Lane
    Foxmount Farm Old Brookville
    FOREIGN New York 11545
    Usa
    Geschäftsführer
    Hoaglands Lane
    Foxmount Farm Old Brookville
    FOREIGN New York 11545
    Usa
    American29524290001
    D`ALTON, Paul Michael
    Adare
    Carrickbrennan Road
    IRISH Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Adare
    Carrickbrennan Road
    IRISH Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    British43460730001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish114320980001
    GAVIN, Moira
    15 Eaton Square
    SW1W 9DD London
    Geschäftsführer
    15 Eaton Square
    SW1W 9DD London
    American94611370002
    GLEDHILL, Hugh Thomas Orlando
    Aston Grange Aston
    ST15 0BJ Stone
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Aston Grange Aston
    ST15 0BJ Stone
    Staffordshire
    United KingdomBritish29524300001
    GOULANDRIS, Peter John
    Sea Saga,Edgewater Drive
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Geschäftsführer
    Sea Saga,Edgewater Drive
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    BahamasBahamian62854330004
    GUILLAUMIN, Denis
    35 Princes Gate Court
    SW7 2QJ London
    Geschäftsführer
    35 Princes Gate Court
    SW7 2QJ London
    French55923040002
    HAIG, Gavin
    44 Marsh Lane
    CW5 5LH Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    44 Marsh Lane
    CW5 5LH Nantwich
    Cheshire
    British68733980001
    HARPER, Timothy Wallace
    Hillcroft
    Stoney Lane, Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Hillcroft
    Stoney Lane, Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    British68733880002
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    JENNER, Edward
    Moorside 6 Pipers Lane
    Lower Heswell
    L60 9HP Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Moorside 6 Pipers Lane
    Lower Heswell
    L60 9HP Wirral
    Merseyside
    British41630860001
    JOHNSON, Christopher John Staley
    Kibblestone House
    Oulton Heath
    ST15 8US Stone
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Kibblestone House
    Oulton Heath
    ST15 8US Stone
    Staffordshire
    British8248530001
    JOHNSON, Robert Lewis
    The Old Smithy Gorsey Bank
    Standon
    ST21 6RB Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Old Smithy Gorsey Bank
    Standon
    ST21 6RB Stafford
    Staffordshire
    British8248540001
    LITTLE, Roger Forsyth
    Dayhills House
    ST15 7RU Stone
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Dayhills House
    ST15 7RU Stone
    Staffordshire
    Australian117682010001
    MCGILLIVARY, Christopher John
    3864 West Gulf Drive
    Sanibel Island
    Florida
    33957
    United States
    Geschäftsführer
    3864 West Gulf Drive
    Sanibel Island
    Florida
    33957
    United States
    American117682040001
    MCGORAN, Kevin Columba
    Longwood
    7 Herbert Park
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Geschäftsführer
    Longwood
    7 Herbert Park
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    IrelandIrish15442070001
    NIEHAUS, Robert Henry
    105 Evergreen Avenue
    Rye New York 10580
    FOREIGN United States Of America
    Geschäftsführer
    105 Evergreen Avenue
    Rye New York 10580
    FOREIGN United States Of America
    American46823720002
    NUTBEEN, Wayne Jonathan
    The Kent
    Highgrove House Ancoates Lane
    SK9 7TT Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Kent
    Highgrove House Ancoates Lane
    SK9 7TT Alderley Edge
    Cheshire
    British63586300004
    O'DONOGHUE, Patrick Redmond
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    Geschäftsführer
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    Irish77402680001
    O'HAGAN, Leonard John Patrick
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Irish15365240001
    O'REILLY, Anthony John Francis
    Castlemartin
    Kilcullen
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Geschäftsführer
    Castlemartin
    Kilcullen
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish46823690001
    O'REILLY, Chryssanthie Jane
    Lissadell
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Geschäftsführer
    Lissadell
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Greek39590670001
    PATTERSON, Brian David
    8 Trentham Court
    Park Drive Trentham
    ST4 8FB Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    8 Trentham Court
    Park Drive Trentham
    ST4 8FB Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Irish50417460001
    RITCHIE, Robin James
    106 Rodenhurst Road
    SW4 8AP London
    Geschäftsführer
    106 Rodenhurst Road
    SW4 8AP London
    EnglandBritish29524320001
    SMITH, Andrew
    5 Brendon Way
    LE65 1EY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    5 Brendon Way
    LE65 1EY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British60416710002
    STONIER, George
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish8248550001
    WEDGWOOD, Francis Alan
    Barton House
    Pooley Bridge
    CA10 2NG Penrith
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Barton House
    Pooley Bridge
    CA10 2NG Penrith
    Cumbria
    British29524330002
    WEDGWOOD, Piers Anthony Weymouth, Lord
    152
    Ashley Gardens
    SW1 London
    Geschäftsführer
    152
    Ashley Gardens
    SW1 London
    British56478560002

    Hat WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 15. Aug. 2008
    Geliefert am 23. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £157,017.90 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest in the deposit being £157,017.90 plus other monies see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daejan Investments Limited
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2005
    Geliefert am 05. Jan. 2006
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America N.A. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Securities pledge agreement
    Erstellt am 20. Dez. 2005
    Geliefert am 05. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the other creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The securities described in schedule 1.2(a) of the securities pledge agreement (being 363 class b shares in certificate number b-6 of waterford wedgwood canada inc.(the securities)) and any cash dividends options warrants securities instruments or other monies intangibles proceeds or other property received or declared in respect of the securities and all other rights and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America, N.A.
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession to a debenture dated 30 september 2004
    Erstellt am 03. März 2005
    Geliefert am 10. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All group shares and related rights present or future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wachovia Bank, National Association (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2004
    Geliefert am 07. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An intercreditor and security trust agreement
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 17. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to a senior creditor or to an hyb creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    If the company receives from a third party a payment or distribution which should have been paid to the security trustee or a creditor the company must promptly pay to the security trustee the amount received by it and required to be prepaid any amount so received by the company from the third party shall be held by it on trust until such payment is made any amount so received by the security trustee will be applied against the debt in the order provided for under the intercreditor. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security over shares
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 11. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares, all other shares in the capital of the canadian subsidiary, and all warrants options or pther rights to acquire such shares, all securities instruments negotiable documents of title and other personal property of any kind. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security over shares agreement
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 09. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first fixed charge all the shares and by way of a first fixed charge all the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over a bank account
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 09. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all of its right title and interest in the accounts (being euro accounts nos. 52711170 and 31706620) and the account balances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 09. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The debtor grants to the secured party for the benefit of the creditors a continuing security interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 09. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 28. Feb. 1994
    Geliefert am 15. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of each of the finance documents and the existing facilities (as defined)
    Kurze Angaben
    (I) the shares and all dividends and (ii) all stocks, shares and other securities owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Feb. 1994
    Geliefert am 09. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) under the terms of the finance documents and existing facilities defined therein
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 03. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the existing facilities or the refinancing agreement of over date.
    Kurze Angaben
    (See 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 03. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under te terms of the refinancing agreement of even date & the indebtedness agreements.
    Kurze Angaben
    (See 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 02. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to national westminster bank PLC as agent and trustee for itself and for ech bank (as defined) under the terms of the finance documents and existing facilities defined therein.
    Kurze Angaben
    (Please see doc for details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 21. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Mai 2011Ende der Verwaltung
    05. Jan. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Angus Matthew Martin
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Praktiker
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Nicholas James Dargan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    2
    DatumTyp
    21. Mai 2017Soll aufgelöst werden am
    10. Mai 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Angus Matthew Martin
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0