GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02058727 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?
- (7222) /
- (7499) /
Wo befindet sich GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1200 Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DCS MOTIS LIMITED | 31. Mai 1994 | 31. Mai 1994 |
| MOTIS SYSTEMS (UK) LIMITED | 15. Sept. 1987 | 15. Sept. 1987 |
| LOCKE COMPUTING SERVICES LIMITED | 18. Aug. 1987 | 18. Aug. 1987 |
| DALEVOTE LIMITED | 26. Sept. 1986 | 26. Sept. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | Seiten | GAZ1(A) | ||
legacy | Seiten | 652a | ||
legacy | Seiten | 363a | ||
legacy | Seiten | 363a | ||
legacy | Seiten | 287 | ||
legacy | Seiten | 190 | ||
legacy | Seiten | 353 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | Seiten | AA | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | Seiten | AA | ||
legacy | Seiten | 287 | ||
legacy | Seiten | 288a | ||
legacy | Seiten | 288b | ||
legacy | Seiten | 363a | ||
legacy | Seiten | 288a | ||
legacy | Seiten | 288a | ||
legacy | Seiten | 288b | ||
legacy | Seiten | 288b | ||
legacy | Seiten | 288b | ||
legacy | Seiten | 403a | ||
legacy | Seiten | 403a | ||
legacy | Seiten | 288c | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | Seiten | AA | ||
legacy | Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSS, Michael Craig | Sekretär | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | American | 121496770001 | ||||||
| BURNETT, Robert David | Geschäftsführer | Post Oak Run 77355 Magnolia 28122 Texas Usa | United States | American | 121495910001 | |||||
| MOSS, Michael Craig | Geschäftsführer | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | United States | American | 121496770001 | |||||
| BATE, Nicholas John | Sekretär | St James Court 107 Wilderspool Causeway WA4 6PS Warrington Cheshire | British | 10672220001 | ||||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Sekretär | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Sekretär | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| CAMPBELL, Colin Stephen | Sekretär | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | British | 89866330001 | ||||||
| ROGERS, Wendy Fiona | Sekretär | Fulbrook House 14 West End HP22 5TT Weston Turville Buckinghamshire | British | 72773920003 | ||||||
| SMITH, David Anthony | Sekretär | 15 Waveney Drive WA14 4UQ Altrincham Cheshire | British | 17924810001 | ||||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Geschäftsführer | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| CAMPBELL, Colin Stephen | Geschäftsführer | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | United Kingdom | British | 89866330001 | |||||
| ELLIS, Nicholas Edward | Geschäftsführer | Westham Lodge Wellesbourne Road CV35 8DS Barford Warwickshire | United Kingdom | British | 81206820001 | |||||
| EMBLEY, Paul | Geschäftsführer | 23 Roosevelt Avenue SG17 5UR Shefford Bedfordshire | British | 66065980001 | ||||||
| FABRE, Jeremie | Geschäftsführer | 4 Rue Du Lac Messery 74140 France | French | 116364550001 | ||||||
| FLEGG, Ronald Edwin | Geschäftsführer | 28 Grange Farm Drive Stockton CV47 8FT Southam Warwickshire | British | 10672250002 | ||||||
| HARRISON, Jeffrey Malcolm | Geschäftsführer | 54 Stratford Road B60 1AU Bromsgrove Worcestershire | British | 16150470002 | ||||||
| KIDD, John | Geschäftsführer | 10 Ashmeade Halebarns WA15 0DB Altrincham Cheshire | England | British | 10672230001 | |||||
| MACKENZIE, Iain Robertson | Geschäftsführer | Corbett House 15 Corbett Avenue WR9 7BE Droitwich Worcestershire | British | 35613150001 | ||||||
| MARTIN, Robert Edward | Geschäftsführer | 25 Syddal Road Bramhall SK7 1AB Stockport Cheshire | England | British | 24767980001 | |||||
| MERRIMAN, Christopher Peter | Geschäftsführer | 1 Oakdene Drive Barnt Green B45 8LQ Birmingham West Midlands | British | 63578740002 | ||||||
| SANT, Andrew Jonathan | Geschäftsführer | The Granary Marton Road CV23 8EH Birdingbury Warwickshire | British | 82342040002 | ||||||
| SMITH, David Anthony | Geschäftsführer | 15 Waveney Drive WA14 4UQ Altrincham Cheshire | British | 17924810001 | ||||||
| SOANES, David | Geschäftsführer | Fencewood House Slanting Hill RG18 9QQ Cold Ash Berkshire | British | 80021380001 | ||||||
| SPENCE, Raymond Leslie | Geschäftsführer | 1 Mill Lane WS14 0DP Lichfield Staffordshire | British | 46677090001 | ||||||
| STERKENBURG, Daniel Richard | Geschäftsführer | Rue De L'Eglise 7 Crans-Pres-Celigny 1299 Switzerland | American | 116364510001 | ||||||
| WOODALL, Frederick Peter | Geschäftsführer | The Ridge Pine Walks Prenton CH42 8NF Wirral Merseyside | British | 74795530001 | ||||||
| YAPP, Stephen | Geschäftsführer | 4 The Tovells Off School Lane Ufford IP13 6HF Woodbridge Suffolk | England | British | 42686850001 |
Hat GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Okt. 2005 Geliefert am 21. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 12. März 2004 Geliefert am 01. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Jan. 1995 Geliefert am 27. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade and tenants fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of copyright and design right | Erstellt am 21. Feb. 1994 Geliefert am 09. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A)all copyrights and rights in the nature of copyright now belonging to the company throughout the world.b)all design rights now belonging to the company throughout the world.c)all copyrights,design rights and rights in the nature of copyright throughout the world.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over goodwill trade marks and tradenames | Erstellt am 21. Feb. 1994 Geliefert am 09. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1."Charged rights" means all trade marks,trade mark applications,tradenames and other rights and interests charged.2."trade marks" means united kingdom trade marks,including service marks or where the context requires,the equivalent in other local jurisdictions.by way of fixed charge:-a)all the trade marks listed in the schedule.b)all interests or rights of the company,both present and future in trade marks or tradenames.c)all other goodwill,both present and future,of the company and all tradenames.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 08. Nov. 1991 Geliefert am 28. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 & this charge | |
Kurze Angaben The motis software rights.....the computer programmes....the operating manuels....the media....all rights to the mark and/or name "motis"....please see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Nov. 1991 Geliefert am 28. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 & this charge | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Nov. 1991 Geliefert am 28. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 6/11/91 & this charge | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 08. Nov. 1991 Geliefert am 29. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 and this charge | |
Kurze Angaben The motis software rights....the computer programmes....the operating programmes....the media....all rights to the mark and/or name "motis"....please see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juni 1989 Geliefert am 17. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of charge. | |
Kurze Angaben The motis software materials as defined in clause 1 of the assignment. See contribution sheet to ford 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 30. Juni 1989 Geliefert am 17. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the assignment of even date. | |
Kurze Angaben The motis software materials as defined clause 1 of the assignment. See contribution sheet to form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 1988 Geliefert am 11. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0