GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED

GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02058727
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    • (7222) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DCS MOTIS LIMITED31. Mai 199431. Mai 1994
    MOTIS SYSTEMS (UK) LIMITED15. Sept. 198715. Sept. 1987
    LOCKE COMPUTING SERVICES LIMITED18. Aug. 198718. Aug. 1987
    DALEVOTE LIMITED26. Sept. 198626. Sept. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    SeitenGAZ1(A)

    legacy

    Seiten652a

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten287

    legacy

    Seiten190

    legacy

    Seiten353

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    SeitenAA

    legacy

    Seiten287

    legacy

    Seiten288a

    legacy

    Seiten288b

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten288a

    legacy

    Seiten288a

    legacy

    Seiten288b

    legacy

    Seiten288b

    legacy

    Seiten288b

    legacy

    Seiten403a

    legacy

    Seiten403a

    legacy

    Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    SeitenAA

    legacy

    Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Sekretär
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    American121496770001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121495910001
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121496770001
    BATE, Nicholas John
    St James Court 107 Wilderspool Causeway
    WA4 6PS Warrington
    Cheshire
    Sekretär
    St James Court 107 Wilderspool Causeway
    WA4 6PS Warrington
    Cheshire
    British10672220001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Sekretär
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Sekretär
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Sekretär
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    ROGERS, Wendy Fiona
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    British72773920003
    SMITH, David Anthony
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    British17924810001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Geschäftsführer
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Geschäftsführer
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    United KingdomBritish89866330001
    ELLIS, Nicholas Edward
    Westham Lodge
    Wellesbourne Road
    CV35 8DS Barford
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Westham Lodge
    Wellesbourne Road
    CV35 8DS Barford
    Warwickshire
    United KingdomBritish81206820001
    EMBLEY, Paul
    23 Roosevelt Avenue
    SG17 5UR Shefford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    23 Roosevelt Avenue
    SG17 5UR Shefford
    Bedfordshire
    British66065980001
    FABRE, Jeremie
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    Geschäftsführer
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    French116364550001
    FLEGG, Ronald Edwin
    28 Grange Farm Drive
    Stockton
    CV47 8FT Southam
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    28 Grange Farm Drive
    Stockton
    CV47 8FT Southam
    Warwickshire
    British10672250002
    HARRISON, Jeffrey Malcolm
    54 Stratford Road
    B60 1AU Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    54 Stratford Road
    B60 1AU Bromsgrove
    Worcestershire
    British16150470002
    KIDD, John
    10 Ashmeade
    Halebarns
    WA15 0DB Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10 Ashmeade
    Halebarns
    WA15 0DB Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish10672230001
    MACKENZIE, Iain Robertson
    Corbett House 15 Corbett Avenue
    WR9 7BE Droitwich
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Corbett House 15 Corbett Avenue
    WR9 7BE Droitwich
    Worcestershire
    British35613150001
    MARTIN, Robert Edward
    25 Syddal Road
    Bramhall
    SK7 1AB Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    25 Syddal Road
    Bramhall
    SK7 1AB Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish24767980001
    MERRIMAN, Christopher Peter
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    British63578740002
    SANT, Andrew Jonathan
    The Granary
    Marton Road
    CV23 8EH Birdingbury
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Granary
    Marton Road
    CV23 8EH Birdingbury
    Warwickshire
    British82342040002
    SMITH, David Anthony
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    British17924810001
    SOANES, David
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    British80021380001
    SPENCE, Raymond Leslie
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    British46677090001
    STERKENBURG, Daniel Richard
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    American116364510001
    WOODALL, Frederick Peter
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    British74795530001
    YAPP, Stephen
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish42686850001

    Hat GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Okt. 2005
    Geliefert am 21. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 01. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 1995
    Geliefert am 27. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade and tenants fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of copyright and design right
    Erstellt am 21. Feb. 1994
    Geliefert am 09. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A)all copyrights and rights in the nature of copyright now belonging to the company throughout the world.b)all design rights now belonging to the company throughout the world.c)all copyrights,design rights and rights in the nature of copyright throughout the world.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over goodwill trade marks and tradenames
    Erstellt am 21. Feb. 1994
    Geliefert am 09. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1."Charged rights" means all trade marks,trade mark applications,tradenames and other rights and interests charged.2."trade marks" means united kingdom trade marks,including service marks or where the context requires,the equivalent in other local jurisdictions.by way of fixed charge:-a)all the trade marks listed in the schedule.b)all interests or rights of the company,both present and future in trade marks or tradenames.c)all other goodwill,both present and future,of the company and all tradenames.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 08. Nov. 1991
    Geliefert am 28. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 & this charge
    Kurze Angaben
    The motis software rights.....the computer programmes....the operating manuels....the media....all rights to the mark and/or name "motis"....please see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 1991
    Geliefert am 28. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 & this charge
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 1991
    Geliefert am 28. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 6/11/91 & this charge
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tameside Metropolitan Borough Council
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 08. Nov. 1991
    Geliefert am 29. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 and this charge
    Kurze Angaben
    The motis software rights....the computer programmes....the operating programmes....the media....all rights to the mark and/or name "motis"....please see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tameside Metropolitan Borough Council
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1989
    Geliefert am 17. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of charge.
    Kurze Angaben
    The motis software materials as defined in clause 1 of the assignment. See contribution sheet to ford 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Motis Systems Inc.
    Transaktionen
    • 17. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 09. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 30. Juni 1989
    Geliefert am 17. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the assignment of even date.
    Kurze Angaben
    The motis software materials as defined clause 1 of the assignment. See contribution sheet to form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Motis Systems Inc
    Transaktionen
    • 17. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 09. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 1988
    Geliefert am 11. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 03. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0