PINTON ESTATES PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePINTON ESTATES PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02059181
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PINTON ESTATES PLC?

    • (7011) /

    Wo befindet sich PINTON ESTATES PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House,
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PINTON ESTATES PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RAGLAN ESTATES PLC.20. Sept. 199420. Sept. 1994
    LETINVEST PLC10. Dez. 198610. Dez. 1986
    BONUSMERGE PUBLIC LIMITED COMPANY26. Sept. 198626. Sept. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PINTON ESTATES PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für PINTON ESTATES PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 14. Mai 2019

    5 SeitenREC2

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2019

    5 SeitenREC2

    Beendigung der Bestellung von Trafalgar Officers Limited als Geschäftsführer am 01. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2018

    6 SeitenREC2

    Beendigung der Bestellung von Reit (Corporate Services) Limited als Sekretär am 08. Aug. 2017

    2 SeitenTM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2017

    2 Seiten3.6

    Beendigung der Bestellung von Christopher George White als Geschäftsführer am 11. Apr. 2016

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2015

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2014

    5 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2013

    5 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2012

    5 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2011

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2010

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Apr. 2010

    3 Seiten3.6

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    37 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von PINTON ESTATES PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    JACOBS, Adrian Mark
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    Sekretär
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    British59392140001
    PALMER, Martin Trevor Digby
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British79436600001
    SMITH, David Allan
    86 Pymers Mead
    SE21 8NJ London
    Sekretär
    86 Pymers Mead
    SE21 8NJ London
    British6156610001
    WOOLLEY, Roderic Harry
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    Sekretär
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    British1017530003
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    79571870001
    AUSTEN, Jonathan Martin
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    Geschäftsführer
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    British36694850001
    BECKWITH, Peter Michael
    Prospect House
    3 Prospect Place
    SW20 0JP London
    Geschäftsführer
    Prospect House
    3 Prospect Place
    SW20 0JP London
    United KingdomBritish44336530002
    BOISSIER, Rupert John
    9 Agate Road
    W6 0AJ London
    Geschäftsführer
    9 Agate Road
    W6 0AJ London
    British23579140002
    CHALK, Clive Andrew
    12 Rydon Mews
    SW19 4RP Wimbledon
    London
    Geschäftsführer
    12 Rydon Mews
    SW19 4RP Wimbledon
    London
    United KingdomBritish147480740001
    FOSLER, Frederick Alan
    Conkwell Grange
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Geschäftsführer
    Conkwell Grange
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    British14331600001
    HADDO, Alexander, Earl Of Haddo
    22 Beauclerc Road
    W6 0NS London
    Geschäftsführer
    22 Beauclerc Road
    W6 0NS London
    British35007020001
    HOLMAN, Keith Alan
    64 Lansdowne Road
    W11 2LR London
    Geschäftsführer
    64 Lansdowne Road
    W11 2LR London
    British102268330001
    INGALL, Michael Julian
    Quinneys
    High St Cookham
    SL6 9SJ Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Quinneys
    High St Cookham
    SL6 9SJ Maidenhead
    Berkshire
    British46465490001
    LANDERS, Michael Jerome
    Eagles Crag
    Marley Heights
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Eagles Crag
    Marley Heights
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    British123276270001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Geschäftsführer
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Geschäftsführer
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    MEADS, Paul Graham
    8 Mindelheim Avenue
    RH19 3UU East Grinstead
    West Sussex
    Geschäftsführer
    8 Mindelheim Avenue
    RH19 3UU East Grinstead
    West Sussex
    United KingdomBritish124973250001
    NOE, Leopold
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    EnglandBritish64965010001
    PLUMMER, Jeremy James
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    EnglandBritish3994380002
    SADLEIR, William Hugh Granby
    Lads House Lynes Yard
    Bishops Cannings
    SN10 2LS Devizes
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Lads House Lynes Yard
    Bishops Cannings
    SN10 2LS Devizes
    Wiltshire
    British9556360001
    SHEEHAN, Nicholas John Philip
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    British39476870001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Geschäftsführer
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SLOAN, Roderick David Gray
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    British9739700002
    SMITH, David Allan
    86 Pymers Mead
    SE21 8NJ London
    Geschäftsführer
    86 Pymers Mead
    SE21 8NJ London
    British6156610001
    SMITH, Ivor
    3 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    Geschäftsführer
    3 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    United KingdomBritish21120940002
    STRATTON, Peter William
    160 Castelnau
    SW13 9ET London
    Geschäftsführer
    160 Castelnau
    SW13 9ET London
    British48000530001
    STRATTON, Peter William
    160 Castelnau
    SW13 9ET London
    Geschäftsführer
    160 Castelnau
    SW13 9ET London
    British48000530001
    THOMPSON, Alister Lawrence
    10 The Ridings
    GU33 7RP Liss
    Hampshire
    Geschäftsführer
    10 The Ridings
    GU33 7RP Liss
    Hampshire
    EnglandBritish124973110001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish80132540006
    WINFIELD, Peter Stevens
    White Rose Cottage
    George Road Coombe Wood
    KT2 7NR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    White Rose Cottage
    George Road Coombe Wood
    KT2 7NR Kingston Upon Thames
    Surrey
    British30062200001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001

    Hat PINTON ESTATES PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 22. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £70,000,000 and all other monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The single share of £1 in the capital of pinton (cosham) limited together with all future shares rights dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited (The Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 15. Sept. 2004
    Geliefert am 21. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £70,000,000 and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 3RD march 1987 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the interest of the company in the sum of £4,045,00 paid to the trustee by the company.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited (The Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge
    Erstellt am 05. Juni 2000
    Geliefert am 16. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £70,000,000 interest and all other moneys due or to become due from the company to the chargee intended to be secured by a trust deed dated 3 march 1987 as amended by a supplemental deed dated 9 march 1989 and any deed suplemental thereto
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a jones court womanby street cardiff and land on the south east of western avenue cardiff. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 16. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 04. Mai 2000
    Geliefert am 12. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingentand whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company and/or any obligor (as defined in the credit agreement) to each finance party (as defined in the credit agreement) under or pursuant to the credit agreement dated 20/03/00
    Kurze Angaben
    The companys whole rights title and interest in and to the rental income in respect of the properties and all right title and interest in respect of the rental income following a retrocesion of the assignation of rents see form 395 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and Theother Finance Parties
    Transaktionen
    • 12. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH may 2000
    Erstellt am 03. Mai 2000
    Geliefert am 19. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations monies and liabilities due from the company (formerly known as raglan estates PLC) and/or the borrower (as defined) and/or any other obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined) under the credit agreement (as defined) and each finance document referred to in the said credit agreement
    Kurze Angaben
    All and whole those subject at st peter's lane glasgow t/no.GLA37256.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 19. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rent
    Erstellt am 03. Mai 2000
    Geliefert am 17. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement and any other finance document
    Kurze Angaben
    The chargor hereby assigns to the security party in security of the liabilities whatever right title and interest it may have in and to the rental income in respect of the properties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transaktionen
    • 17. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 03. Mai 2000
    Geliefert am 17. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the credit agreement and any fiance document
    Kurze Angaben
    The property knwn as st peter's lane glasgow title number GLA37256. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transaktionen
    • 17. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 03. Mai 2000
    Geliefert am 17. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and laibilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Full title guarantee and as security for the payment of all the secured liabilities charges in favour of the secured party. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transaktionen
    • 17. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 03. Mai 2000
    Geliefert am 17. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    All present and future shares in raglan securities limited, pointer investments limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transaktionen
    • 17. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 02. Mai 2000
    Geliefert am 11. Mai 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £70,000,000 interest and all other moneys intended to be secured by a trust deed dated 03/03/87 as amended by a supplemental deed dated 09/03/89 and made between raglan estates PLC and the chargee and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    All the interest of the company in the sum of £20,664,000 paid to the trustee by the company.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited (The Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed between raglan estates PLC, raglan securities limited, raglan projects limited and the prudential assurance company limited
    Erstellt am 30. März 2000
    Geliefert am 19. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £70,000,000 interest and all moneys intended to be secured by a trust deed dated 03/03/87 as amended by a supplemental deed dated 09/03/89 both made between raglan estates PLC and the chargee and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    The interest of the company in all rents and licence fees interest in respect of the insurances of the specific security please refer to form 395 for further details.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 29. Jan. 1999
    Geliefert am 01. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal and interest on the £70,000,000 11.25 per cent first mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other moneys intended to be secured by this deed and the deeds dated 3 march 1987 and the various deeds supplemetnal thereto
    Kurze Angaben
    4, 5 and 6 savile row london t/n's LN188572 and LN190394 together with al buildings fixtures fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 09. Sept. 1998
    Geliefert am 18. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £70,000,000 11.25 per cent . first mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other monies intended to be secured by the trust deed dated 3RD march 1987 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    The capital sum of £1,818,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 23. Juni 1998
    Geliefert am 24. Juni 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee payment of the principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and various other deeds (all as defined) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sum of £675,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 24. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and subsititution
    Erstellt am 31. März 1998
    Geliefert am 01. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee payment of the principal of and interest on the £70,000,000 11 and one quater per cent. First mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and various other deeds (all as defined) which it is supplemental to
    Kurze Angaben
    The capital sum of £9,100,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 22. Jan. 1998
    Geliefert am 02. Feb. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and deeds of various dates to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sun of £2,344,500 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 08. Dez. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee payment of the principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and various other deeds (all as defined) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sum of £2,053,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 23. Okt. 1997
    Geliefert am 28. Okt. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Payment of the principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other moneys intended to be secured by the deed and supplemental deeds (as defined therein)
    Kurze Angaben
    The capital sum of £3,994,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 26. Sept. 1997
    Geliefert am 30. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Payment of the principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC in favour of the chargee and all monies intended to be secured by the deed of release and substitution and deeds of various dated to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sum of £875,000 and the investments for the time being and from time to time.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 28. Apr. 1997
    Geliefert am 08. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £70,000,0000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2012 of the company in favour of the prudential assurance company limited and all other monies intended to be secured by the deed of release and substitution and deeds of various dates to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sum of £2,884,872 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 08. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 07. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Payment of the principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2012 of the company PLC and all other moneys intended to be secured by this deed of release and substitution and the deed dated 3RD march 1987 and all deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    1. f/h-165-206 (odd, 203A and 205-215 (odd)) new road rubery hereford and worcester t/n-hw 155904. 2. f/h-77-93 (odd) mottingham road 275-281 (odd) court road and garages t/n-tgl 2414. 3. l/h-77-93 inclusive (odd) 77A-93A inclusive (odd) mottingham road 275-281 inclusive (odd) court road t/n-LN207869.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 20. Okt. 1995
    Geliefert am 24. Okt. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Payment of the principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2012 of the company and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sum of £6,153,720 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Charge by way of a deed of release and substitution
    Erstellt am 15. Juni 1995
    Geliefert am 19. Juni 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £70,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2012 of raglan estates PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sum of £3,015,892 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 19. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 21. Apr. 1995
    Geliefert am 26. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £70,000,000 11%. first mortgage debenture stock 2012 of the company and all other monies intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units 1/7C witan park trading estate, station lane industrial estate, witney, oxfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 24. März 1995
    Geliefert am 29. März 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the prudential assurance company limited arising from the interest of £70,000,000 11 1/4 % first mortgage debenture stock 2012 of the company and all other monies intended to be secured under or pursuant to the terms of the deeds ( as defined )
    Kurze Angaben
    All that freehold propetrty known units 28-30 the bossard centre, leighton buzzard , bedfordshire title no bd 120572 together with all buildings and erections and all improvements and additions thereto and fixtures and fixed plant and machinery for the time being thereon .
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 29. März 1995Registrierung einer Belastung (395)

    Hat PINTON ESTATES PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lee Antony Manning
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    London
    Receiver Manager
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Receiver Manager
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0