ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02062760 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Popeshead Court Offices Peter Lane YO1 8SU York England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DANEBARK LIMITED | 09. Okt. 1986 | 09. Okt. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2023 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2022 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2021 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 4 Jubilee Court Copgrove Harrogate North Yorkshire HG3 3TB zum Popeshead Court Offices Peter Lane York YO1 8SU am 20. Okt. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Colin Spencer Tilley as a person with significant control on 31. Juli 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Colin Spencer Tilley als Geschäftsführer am 31. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL, Kathleen Margaret | Sekretär | Hadleigh House 128a Skipton Road LS29 9BQ Ilkley | British | 32895230001 | ||||||
| BELL, Kathleen Margaret | Geschäftsführer | Hadleigh House 128a Skipton Road LS29 9BQ Ilkley | England | British | 32895230001 | |||||
| LOWIN, Richard Ashley | Geschäftsführer | Peter Lane YO1 8SU York Popeshead Court Offices England | England | British | 186097270001 | |||||
| TOOP, Philip George Peter | Geschäftsführer | Peter Lane YO1 8SU York Popeshead Court Offices England | England | British | 147969650001 | |||||
| HAMILTON, Douglas Sinclair | Sekretär | Penlan Faceby TS9 7DA Middlesbrough Cleveland | British | 15832720001 | ||||||
| CLOUGH, Charles Robin | Geschäftsführer | Spital Hill York Road YO7 3AE Thirsk North Yorkshire | England | British | 14187540001 | |||||
| CORDUKES, Peter William | Geschäftsführer | 12 Hall Lane Sutton Lane Ends SK11 0DU Macclesfield Cheshire | British | 15832740001 | ||||||
| HARDY, Catherine Rowena | Geschäftsführer | 8 West End Osmotherley DL6 3AA Northallerton North Yorkshire | England | British | 110100500001 | |||||
| MURRAY, John Hendry | Geschäftsführer | 48 India Street EH3 6HD Edinburgh | British | 23980002 | ||||||
| SLATER, Roy Katen | Geschäftsführer | Red Gables Quarry Moor Lane HG4 1RW Ripon North Yorkshire | England | British | 20696360002 | |||||
| TILLEY, Colin Spencer | Geschäftsführer | Jubilee Court Copgrove HG3 3TB Harrogate Suite 4 North Yorkshire England | England | British | 110100590001 | |||||
| TILLEY, Colin Spencer | Geschäftsführer | 3 Leadhall Crescent HG2 9NG Harrogate North Yorkshire | England | British | 110100590001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Colin Spencer Tilley | 06. Apr. 2016 | Jubilee Court Copgrove HG3 3TB Harrogate Suite 4 North Yorkshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Richard Ashley Lowin | 06. Apr. 2016 | Peter Lane YO1 8SU York Popeshead Court Offices England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Philip George Peter Toop | 06. Apr. 2016 | Peter Lane YO1 8SU York Popeshead Court Offices England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat ASSOCIATED KNOWLEDGE SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 31. Mai 1991 Geliefert am 13. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the turst deed dated 22.12.88 and all other moneys and liabilities due from the company on any accounts whatsoever. | |
Kurze Angaben Amen house and the coach house, north end, bedale hambleton, north yorkshire, title no. Nyk 83213 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery (please see M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 1991 Geliefert am 02. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £175,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Amen house and the coach house the wynd, bedale north yorkshire t/no. Nyk 83213. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juni 1990 Geliefert am 23. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Dez. 1988 Geliefert am 07. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £400,000 and all other moneys due or to become due from the company to caledonion pacific trustees limited under the terms of the charge | |
Kurze Angaben (See form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0