NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02071491
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    160 Great Portland Street
    London
    W1W 5QA
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT NO 2 LIMITED26. Feb. 199926. Feb. 1999
    VIDEOTRON (EQUIPMENT) LIMITED13. Mai 199213. Mai 1992
    VIDEOTRON NO.1 LIMITED16. Apr. 199216. Apr. 1992
    VIDEOTRON CABLE T.V. LIMITED25. Apr. 199025. Apr. 1990
    SOUTH WEST LONDON COMMUNICATIONS LIMITED22. Apr. 198822. Apr. 1988
    LEGIBUS 817 LIMITED06. Nov. 198606. Nov. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    25 SeitenMG01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG04

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Robert Charles Gale als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Robert Mario Mackenzie als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Directors Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Gillian Elizabeth James als Sekretär

    1 SeitenAP03

    legacy

    15 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    8 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Jan. 2010

    Kapitalaufstellung am 22. Jan. 2010

    • Kapital: GBP 24,002
    SH01

    legacy

    18 SeitenMG01

    legacy

    17 SeitenMG01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151344090001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Sekretär
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    HERRMANN, Bradley Laurence
    40 Myddelton Square
    EC1R 1YB London
    Sekretär
    40 Myddelton Square
    EC1R 1YB London
    British24964690001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Geschäftsführer
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    BRUNEL, Louis
    20 Terasse Page
    Ile Bizard
    H9E 1N7 Montreal
    Canada
    Geschäftsführer
    20 Terasse Page
    Ile Bizard
    H9E 1N7 Montreal
    Canada
    Canadian44025400003
    BRUNEL, Louis
    20 Terasse Page
    Ile Bizard
    H9E 1N7 Montreal
    Canada
    Geschäftsführer
    20 Terasse Page
    Ile Bizard
    H9E 1N7 Montreal
    Canada
    Canadian44025400003
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CAVALANCIA, Joseph
    25 West Lodge Avenue
    Acton
    W3 9SE London
    Geschäftsführer
    25 West Lodge Avenue
    Acton
    W3 9SE London
    Canadian40807610001
    CLARKE, Gregory Allison
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    British143319900001
    CLESHAM, Philip
    1 The Old House
    Horseshoe Lane
    GU6 8QL Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 The Old House
    Horseshoe Lane
    GU6 8QL Cranleigh
    Surrey
    British70777230001
    COLLEY, David
    Littlecourt London Road
    St Ippolytts
    SG4 7NE Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Littlecourt London Road
    St Ippolytts
    SG4 7NE Hitchin
    Hertfordshire
    British44423320001
    COLLEY, David
    Littlecourt London Road
    St Ippolytts
    SG4 7NE Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Littlecourt London Road
    St Ippolytts
    SG4 7NE Hitchin
    Hertfordshire
    British44423320001
    DAGENAIS, Jean Charles
    15 Cleeve Park Gardens
    DA14 4JL Sidcup
    Kent
    Geschäftsführer
    15 Cleeve Park Gardens
    DA14 4JL Sidcup
    Kent
    Canadian37128810001
    DEW, Bryony
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    British70776760001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Geschäftsführer
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    EZEKIEL, Marcus David Paul
    26 Broxash Road
    Battersea
    SW11 6AB London
    Geschäftsführer
    26 Broxash Road
    Battersea
    SW11 6AB London
    British42975300001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    HERRMANN, Bradley Laurence
    40 Myddelton Square
    EC1R 1YB London
    Geschäftsführer
    40 Myddelton Square
    EC1R 1YB London
    British24964690001
    HOWELL DAVIES, Peter David
    Wood End
    Beech Lane
    HP9 2SZ Jordans Village
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Wood End
    Beech Lane
    HP9 2SZ Jordans Village
    Buckinghamshire
    British74317800002
    KANE, Nicholas John Aldon
    Weston Mill
    Weston
    RG20 8JB Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Weston Mill
    Weston
    RG20 8JB Newbury
    Berkshire
    British74235930002
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MEARING-SMITH, Nicholas Paul
    Elmfield
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elmfield
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    British2077430001
    MOLYNEUX, Mary Bridget
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Geschäftsführer
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Australian63615470001
    RICHES, Julian
    20 Rossetti Gardens
    CR5 2LR Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    20 Rossetti Gardens
    CR5 2LR Coulsdon
    Surrey
    British42689810001
    RICHTER, Bret
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    Geschäftsführer
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    American86830760001

    Hat NTL EQUIPMENT NO. 2 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charges all right, title and interest in: 1) the english charged land 2) the tangible moveable property 3) the accounts 4) the intellectual property 5) any goodwill 6) the investments 7) the shares and all dividends 8) all monetary claims by way of assignment all right, title and interest in: 1) any insurance policy 2) all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings 3) chattels hired, leased or rented 4) licences held, by way of floating charge the whole undertaking and assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as second security trustee for the secured parties (the "second security trustee")
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 03. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Second Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee")
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 23. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Security Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee") on the terms and conditions set out in the security trust agreement
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 03. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (as defined) or any of the other secured parties (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined) (including the debenture) and including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Mai 1997
    Geliefert am 27. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the credit agreement (as therein defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cable & Wireless Communications PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. März 1995
    Geliefert am 12. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due fro the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the agreement dated 29TH march 1995, the debenture and/or "collateral instruments" (as defined)
    Kurze Angaben
    Property specified in schedule 6. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto Dominion Bank(In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0