HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS
Überblick
| Unternehmensname | HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 02076620 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS?
- Tätigkeiten von Haushalten als Arbeitgeber von Hauspersonal (97000) / Private Haushalte als Arbeitgeber; nicht weiter differenzierte Erwerbstätigkeiten von privaten Haushalten für eigene Zwecke
Wo befindet sich HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Yule Catto Building Temple Fields CM20 2BH Harlow Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SIMCO NO. 152 LIMITED | 24. Nov. 1986 | 24. Nov. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Michael Whitfield als Geschäftsführer am 21. Dez. 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Richard Atkinson als Direktor am 21. Dez. 2012 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKINSON, Richard | Sekretär | Stomps Bacon End CM6 1JW Dunmow Essex | British | 60376890003 | ||||||
| ATKINSON, Richard | Geschäftsführer | Bacon End CM6 1JW Dunmow Stomps Essex United Kingdom | England | British | 60376890003 | |||||
| BURNETT, Andrew David | Geschäftsführer | 25 Ennismore Green LU2 8UP Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 56579020001 | |||||
| HARNETT, John Arthur | Sekretär | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 64013810001 | ||||||
| VICKERS, Jennifer Ann | Sekretär | 8 Slaithwaite Road Scapegoat Hill HD7 3NY Huddersfield West Yorkshire | British | 48328890001 | ||||||
| WALKER, Graham Howard | Sekretär | Hunsinglor 40 Oatlands Drive HG2 8JR Harrogate North Yorkshire | British | 50110280005 | ||||||
| BEYNON, David William Stephen | Geschäftsführer | Laithfield House 20 New Road AL6 0AG Welwyn Hertfordshire | British | 35093960001 | ||||||
| CUMMINS, Sean Vincent | Geschäftsführer | 15 Brooke Gardens CM23 5JF Bishops Stortford Hertfordshire | England | British | 165086580001 | |||||
| DAVISON, Andrew John | Geschäftsführer | 11 Shawfield Street SW3 4BA London | England | British | 2911840001 | |||||
| DONALD, Sidney Milne | Geschäftsführer | 1 Smith Barry Crescent Upper Rissington GL54 2NG Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 64096360001 | |||||
| DONALDSON, Hugh Montgomery | Geschäftsführer | Western Ford New Mill HD7 7DW Huddersfield West Yorkshire | England | British | 60132940001 | |||||
| HARNETT, John Arthur | Geschäftsführer | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 64013810001 | ||||||
| MARTIN, Robert Calder | Geschäftsführer | 8 Millbank Close Chelford SK11 9SJ Macclesfield Cheshire | British | 3514620001 | ||||||
| MCLEISH, Allister Patrick | Geschäftsführer | 10 Roedean Crescent BN2 5RH Brighton East Sussex | United Kingdom | British | 175219580002 | |||||
| PEAGRAM, Michael John | Geschäftsführer | Bletchingdon Park Bletchingdon OX5 3DW Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 44540370005 | |||||
| RAE, Robert Graham | Geschäftsführer | Conifers 11 Eastgate Lund YO25 9TQ Driffield North Humberside | England | Uk | 155216590001 | |||||
| ROBBINS, Mark Ian | Geschäftsführer | Mallorca 262 3 08008 Barcelona Spain | British | 48004850001 | ||||||
| SCOTT, Nicholas Graeme | Geschäftsführer | 16 Deepwell Bank Halfway S19 5SN Sheffield | British | 49524790001 | ||||||
| VICKERS, Jennifer Ann | Geschäftsführer | 8 Slaithwaite Road Scapegoat Hill HD7 3NY Huddersfield West Yorkshire | British | 48328890001 | ||||||
| WALKER, Alexander | Geschäftsführer | Little Firle 23 Avenue Road CM23 5NT Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 46645250002 | |||||
| WELCH, Peter John | Geschäftsführer | Frankfield Spinfield Lane SL7 2LB Marlow Buckinghamshire | British | 1251130001 | ||||||
| WHITFIELD, Adrian Michael | Geschäftsführer | Arden View The Orchard, Wilmcote CV37 9XF Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 71426000002 | |||||
| WILLIAMSON, David Vincent Stewart | Geschäftsführer | Le Millefiori 1 Rue Des Genets MC 98000 Monte-Carlo Monaco | British | 38195590001 |
Hat HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental guarantee and charge | Erstellt am 06. Mai 1994 Geliefert am 20. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under any of a french working capital facility letter dated 5TH may 1994 and the security documents (as defined) and this supplemental charge and all other monies due or to become due from the company to the secured parties (as defined) under the supplemental charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement | Erstellt am 14. Apr. 1994 Geliefert am 21. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and holliday dyes and chemicals limited to the chargee under a loan agreement dated 25TH march 1994 | |
Kurze Angaben All sums standing to the credit of the account of the company maintained with the chargee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 08. Apr. 1993 Geliefert am 20. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein (the debtors) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the credit agreement dated 26/2/93 and each and every document therein defined and/or this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Keyman insurance assignemnt | Erstellt am 08. Apr. 1993 Geliefert am 20. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the credit agreement dated 26/2/93 and each and every document therein defined | |
Kurze Angaben The policies and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and the full benefit thereof and all rights title and interest therein and thereto, the policy being policy number 5186693 and the sum assured being £500,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Keyman insurance assignment | Erstellt am 18. Juni 1992 Geliefert am 02. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties under the terms of the senior facilties agreement dated 14/2/92,the interest rate protection agreements the working capital facility letter,the working capital ancillary facilities letter and the security documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben All rights title and interest in the insurance (as therein defined). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 14. Feb. 1992 Geliefert am 27. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as asgent and trustee for the secured parties (as therein defined) under the terms of the senior facilities agreement, the working capital facility letter, the working capital ancillary facilities letter, the security documents, the interest rate protection agreements (all as therein defined) and under the terms of this charge | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture. | Erstellt am 19. Aug. 1991 Geliefert am 23. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement (as defined) | |
Kurze Angaben (See form 395. ref M121 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 1987 Geliefert am 28. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 09. Sept. 1987 Geliefert am 17. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0