PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02081020 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED?
- Herstellung von Karosserien für Kraftfahrzeuge (außer Wohnwagen) (29201) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link YO30 4XG York North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RAPID 2197 LIMITED | 05. Dez. 1986 | 05. Dez. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Change of details for Arriva (2007) Limited as a person with significant control on 10. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP zum 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link York North Yorkshire YO30 4XG am 13. März 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 27. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lorna Edwards als Direktor am 27. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Antony Bowd als Geschäftsführer am 27. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mark Antony Bowd als Direktor am 22. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Charles Barlow als Geschäftsführer am 27. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alexander Donald Perry als Geschäftsführer am 31. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Evans als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lorna Edwards als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Davies als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alfred Lloyd als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARDS, Lorna | Sekretär | James Nicolson Link YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | 183723900001 | |||||||
| EDWARDS, Lorna | Geschäftsführer | James Nicolson Link YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | England | British | 205425080001 | |||||
| BERWICK, Christopher Robin | Sekretär | 3 Latimer Close Blaby LE8 4AP Leicester Leicestershire | British | 16363440002 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Sekretär | 4 Waterfield Road Cropston LE7 7HN Leicester | British | 35116070001 | ||||||
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Sekretär | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BARLOW, John Charles | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 66466620003 | |||||
| BAYFIELD, Stephen | Geschäftsführer | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BOWD, Mark Antony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWD, Mark Antony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWLER, Richard Charles | Geschäftsführer | 203 Bracenose Driftway Cowley OX4 4LY Oxford Oxfordshire | British | 51739150004 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 4 Waterfield Road Cropston LE7 7HN Leicester | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 35116070003 | |||||
| DYBALL, Richard Charles | Geschäftsführer | 110 Upper Harlestone NN7 4EL Northampton | British | 33781930001 | ||||||
| EVANS, Matthew John | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 197082950001 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 21961900003 | |||||
| JONES, Michael Adrian | Geschäftsführer | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LLOYD, Alfred | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 131555780001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MASON, Catherine Lois | Geschäftsführer | Willow House 135 The Ridings LE7 7SL Rothley Leicestershire | England | British | 81871010001 | |||||
| MCINTOSH, Stuart Gordon | Geschäftsführer | 5 Edgeley Road Countesthorpe LE8 5QN Leicester | British | 77981650001 | ||||||
| PERRY, Alexander Donald | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 80583190002 | |||||
| PICKERING, Gerald | Geschäftsführer | Reasby Mill Cottage Thrussington Road LE7 8SQ Ratcliffe On The Wreake Leicester | British | 16319610002 | ||||||
| RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| WATT, Gordon George | Geschäftsführer | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | 67622780002 | |||||
| WILLIAMS, Dawson Thomas | Geschäftsführer | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | 2719600006 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriva Uk Bus Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 15. Juni 1995 Geliefert am 20. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Apr. 1992 Geliefert am 02. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Jan. 1987 Geliefert am 09. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Jan. 1987 Geliefert am 04. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PICKERING'S TRANSPORT SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0