MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED

MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02081457
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    66 Chiltern Street
    W1U 4JT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OFFERSTRETCH LIMITED08. Dez. 198608. Dez. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 66 Wigmore Street London W1U 2SB United Kingdom am 06. Jan. 2011

    2 SeitenAD01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    3 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    14 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    12 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    7 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2003

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GUDKA, Priyen
    12 Winchfield Close
    HA3 0DT Harrow
    Middlesex
    Sekretär
    12 Winchfield Close
    HA3 0DT Harrow
    Middlesex
    British79135930001
    GUDKA, Priyen
    12 Winchfield Close
    HA3 0DT Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    12 Winchfield Close
    HA3 0DT Harrow
    Middlesex
    EnglandBritish79135930001
    LEIGH, Dudley Stephen
    28 Rosecroft Avenue
    NW3 7QB London
    Geschäftsführer
    28 Rosecroft Avenue
    NW3 7QB London
    EnglandBritish1911440001
    ORCHARD, John Stephen
    18 Corsica Street
    N5 1JN London
    Geschäftsführer
    18 Corsica Street
    N5 1JN London
    United KingdomBritish71501180003
    SMITH, Graham Edward
    40 Braemore Road
    BN3 4HB Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    40 Braemore Road
    BN3 4HB Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish53261020002
    QUINN, Maureen
    Nether Crutches
    Copse Lane
    HP9 2TA Jordans
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Nether Crutches
    Copse Lane
    HP9 2TA Jordans
    Buckinghamshire
    British77695540001
    MANN, Alan Peter Harry
    Red Kites, Innings Road
    Little Frieth
    RG9 6NR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Red Kites, Innings Road
    Little Frieth
    RG9 6NR Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish86447520001
    QUINN, Maureen
    Nether Crutches
    Copse Lane
    HP9 2TA Jordans
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Nether Crutches
    Copse Lane
    HP9 2TA Jordans
    Buckinghamshire
    British77695540001

    Hat MELVILLE HEATH PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Third party legal charge
    Erstellt am 09. Aug. 2005
    Geliefert am 15. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from marchday group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property being strahan house avon street bath t/n AV6637,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 04. Nov. 2002
    Geliefert am 14. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from marchday (properties) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a strahan house avon street bath BA1 1UN t/n AV6637. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Mai 2000
    Geliefert am 02. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee all liabilities of the chargor to any of the beneficiaries as defined!
    Kurze Angaben
    F/H property k/a strahan house avon street bath avon - AV6637. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 1993
    Geliefert am 08. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the marchday group PLC to the royal bank of scotland PLC on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage:-all that f/h and l/h land and buildings k/a westpac house 43/45 moorbridge road maidenhead berkshire t/n'S.BK272719,BK192295 and BK193526. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1988
    Geliefert am 15. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All that and those or parcels of land situate at and having a frontage to priory road, high wycombe buckinghamshire. All that and those or parcel of land situate at the rear of the wesley methodist-church priory road high wycombe county of buckingham.
    Berechtigte Personen
    • Credit Commercial De France
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    Deed of assignment
    Erstellt am 28. Sept. 1987
    Geliefert am 15. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge dated 28TH august 1987.
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest in and to all sums due and that may become due as detculedon doc M395 (see doc M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Aug. 1987
    Geliefert am 11. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a nos 32-35 high street, burron-upon-trent in the county of stafford.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Sept. 1987Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0