INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED

INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02083115
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INFOR BUSINESS SOLUTIONS LTD08. Okt. 200308. Okt. 2003
    INFOR:SWAN BUSINESS SOLUTIONS LIMITED17. Jan. 200017. Jan. 2000
    SWAN SOFTWARE GROUP LIMITED31. Dez. 199831. Dez. 1998
    SWAN PRODUCTION SOFTWARE LIMITED29. Juni 198729. Juni 1987
    SWAN PRODUCTION SYSTEMS LIMITED 28. Apr. 198728. Apr. 1987
    FRONTSIGN SOFTWARE LIMITED11. Dez. 198611. Dez. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom One Central Boulevard Blythe Valley Park, Shirley Solihull B90 8BG England zum Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE am 07. Mai 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    8 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Apr. 2019

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2018

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2017

    8 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Phoenix Building Central Boulevard Blythe Valley Park Shirley Solihull West Midlands B90 8BG zum One Central Boulevard Blythe Valley Park, Shirley Solihull B90 8BG am 02. Feb. 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 218.7704
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2015

    11 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 22. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 218.77
    4 SeitenSH19

    Wer sind die Geschäftsführer von INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    Hidden River Road
    FOREIGN Penn Valley
    300
    Pennsylvania 19072-1111
    United States
    Sekretär
    Hidden River Road
    FOREIGN Penn Valley
    300
    Pennsylvania 19072-1111
    United States
    American112513570001
    ALLSOP, Jane Ann
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    Shirley
    B90 8BG Solihull
    The Phoenix Building
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    Shirley
    B90 8BG Solihull
    The Phoenix Building
    West Midlands
    England
    EnglandBritish194821180001
    CZASZNICKI, George
    Green Lane
    Burnham
    SL1 8EB Slough
    58
    Berks.
    Geschäftsführer
    Green Lane
    Burnham
    SL1 8EB Slough
    58
    Berks.
    United KingdomBritish127388860001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    Hidden River Road
    FOREIGN Penn Valley
    300
    Pennsylvania 19072-1111
    Usa
    Geschäftsführer
    Hidden River Road
    FOREIGN Penn Valley
    300
    Pennsylvania 19072-1111
    Usa
    United StatesAmerican112513570001
    KASPER, Jochen Berthold
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    Geschäftsführer
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    GermanyGerman113569900002
    BRAZIER, Morna
    Newlands
    Church Lane Norton
    WR5 2PR Worcester
    Sekretär
    Newlands
    Church Lane Norton
    WR5 2PR Worcester
    British14596950001
    SAUNDERS, Christine
    Elmbridge House
    60 Greenhill, Blackwell
    B60 1BL Bromsgrove
    Worcestershire
    Sekretär
    Elmbridge House
    60 Greenhill, Blackwell
    B60 1BL Bromsgrove
    Worcestershire
    British77615330001
    SHAW, Denys
    1 Cornmill Close
    Elmley Castle
    WR10 3JH Pershore
    Worcestershire
    Sekretär
    1 Cornmill Close
    Elmley Castle
    WR10 3JH Pershore
    Worcestershire
    British12409570001
    BISNOUGHT, George
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    United KingdomBritish140313340001
    BRAZIER, Morna
    Newlands
    Church Lane Norton
    WR5 2PR Worcester
    Geschäftsführer
    Newlands
    Church Lane Norton
    WR5 2PR Worcester
    British14596950001
    BRAZIER, Paul Frank
    Newlands Farm
    Church Lane, Norton
    WR5 2PR Worcester
    Geschäftsführer
    Newlands Farm
    Church Lane, Norton
    WR5 2PR Worcester
    EnglandBritish86259000001
    BURKE, Richard Norman
    Ash Cottage
    Ford
    GL54 5RU Temple Guiting
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Ash Cottage
    Ford
    GL54 5RU Temple Guiting
    Gloucestershire
    EnglandBritish204699000001
    CULLENS, Russell Alan
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hants
    Geschäftsführer
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hants
    British117348310001
    DEANE, Keith
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish113569550001
    HARRIS, Keith
    Danescroft 37 Kingsway
    SL9 8NX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Danescroft 37 Kingsway
    SL9 8NX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British2542580001
    HERTEL, Joachim, Dr
    Ravelstrasse
    Riegelsberg
    66292 Saarland
    Germany
    Geschäftsführer
    Ravelstrasse
    Riegelsberg
    66292 Saarland
    Germany
    German91340120001
    HOLMES, Anne
    Yonder House
    Cheltenham Road
    GL7 2HX Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Yonder House
    Cheltenham Road
    GL7 2HX Cirencester
    Gloucestershire
    British85114180001
    HOLMES, Edward James Alfred
    21 Mandara Grove
    Abbeydale
    GL4 9XT Gloucester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    21 Mandara Grove
    Abbeydale
    GL4 9XT Gloucester
    Gloucestershire
    British21999300001
    MCCARTHY, Shaun Michael
    121 Tanhouse Lane
    WR14 1LG Malvern
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    121 Tanhouse Lane
    WR14 1LG Malvern
    Worcestershire
    British93515910001
    MINTZEL, Christian
    Richard Wagner Strasse 81
    Monchengladbach
    41065
    Germany
    Geschäftsführer
    Richard Wagner Strasse 81
    Monchengladbach
    41065
    Germany
    German78542750001
    MINTZEL, Christian
    Richard Wagner Strasse 81
    Monchengladbach
    41065
    Germany
    Geschäftsführer
    Richard Wagner Strasse 81
    Monchengladbach
    41065
    Germany
    German78542750001
    OLDROYD, Andrew
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish136724940001
    REINICKE, Andreas
    Obstwiesengasse 6a
    Fuchshain
    D-04683
    Germany
    Geschäftsführer
    Obstwiesengasse 6a
    Fuchshain
    D-04683
    Germany
    German67700770001
    REINICKE, Andreas
    Obstwiesengasse 6a
    Fuchshain
    D-04683
    Germany
    Geschäftsführer
    Obstwiesengasse 6a
    Fuchshain
    D-04683
    Germany
    German67700770001
    REYNOLDS, Peter William
    Withyholt 6 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Withyholt 6 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich
    Worcestershire
    British8860030001
    RUSKIN, Derek John
    29 Droitwich Road
    Barbourne
    WR3 7LG Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    29 Droitwich Road
    Barbourne
    WR3 7LG Worcester
    Worcestershire
    British32174460004
    SAUNDERS, Christine
    Elmbridge House
    60 Greenhill, Blackwell
    B60 1BL Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Elmbridge House
    60 Greenhill, Blackwell
    B60 1BL Bromsgrove
    Worcestershire
    British77615330001
    SCHAPER, James Carl
    635 Brisbane Manor
    Alpharetta
    Ga
    30022
    Usa
    Geschäftsführer
    635 Brisbane Manor
    Alpharetta
    Ga
    30022
    Usa
    American105503190001
    SHAW, Denys
    1 Cornmill Close
    Elmley Castle
    WR10 3JH Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    1 Cornmill Close
    Elmley Castle
    WR10 3JH Pershore
    Worcestershire
    British12409570001
    SPRAGG, Michael Charles
    9 Westerham Close
    Knowle
    B93 9BU Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    9 Westerham Close
    Knowle
    B93 9BU Solihull
    West Midlands
    British96751400001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Infor (Solihull) Ltd
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park, Shirley
    B90 8BG Solihull
    One
    England
    06. Apr. 2016
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park, Shirley
    B90 8BG Solihull
    One
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer4426846
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A supplemental deed
    Erstellt am 14. Juli 2011
    Geliefert am 28. Juli 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jpmorgan Chase Bank N.A. as Administrative Agent
    Transaktionen
    • 28. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed
    Erstellt am 12. Apr. 2010
    Geliefert am 30. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A. as Administrative Agent
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A second-lien guarantee and collateral agreement
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 19. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers and each loan party to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest in to and under (I) the shares of capital stock and other equity interests owned and any other equity interests obtained in the future and in all such cases the certificates representing all such equity interests. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, Cayman Islands Branch, in Its Capacity as Administrative Agent
    Transaktionen
    • 19. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of amendment
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 19. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A. as Administrative Agent
    Transaktionen
    • 19. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A reaffirmation agreement
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 19. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers and each loan party to the chargee, a lender or an affiliate of a lender and any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the shares of capital stock and other equity interest the debt securities promissory notes all other property all payments of principal or interest dividends accounts chattel paper cash and deposit accounts D. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J P Morgan Chase Bank, N.A., in Its Capacity as Administrative Agent
    Transaktionen
    • 19. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Second-lien debenture
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 19. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, Cayman Islands Branch as Administrative Agent
    Transaktionen
    • 19. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee and collateral agreement
    Erstellt am 28. Juli 2006
    Geliefert am 17. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers and each loan party to the chargee, a lender or an affiliate of a lender and any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the shares of capital stock and other equity interest, the debt securities, promissory notes, all other property, all payments of principal or interest dividends, accounts chattel paper cash and deposit accounts, documents, equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J P Morgan Chase Bank N.A. (The Administrative Agent)
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 2006
    Geliefert am 17. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the restricted chargors in respect of such part of the initial term loans the delayed draw term loan the revolving loans and in relation to any other chargor all of the obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jpmorgan Chase Bank N.A. as Administrative Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Amended and restated guarantee and collateral agreement (the "collateral agreement")
    Erstellt am 14. März 2006
    Geliefert am 03. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (A) all accounts; (b) all chattel paper; (c) all deposit accounts; (d) all documents; (e) all equipment; (f) all general intangibles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A. (The "Collateral Agent")
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. März 2006
    Geliefert am 03. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jpmorgan Chase Bank N.A. as Collateral Agent
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amended and restated second-lien guarantee and collateral agreement
    Erstellt am 14. März 2006
    Geliefert am 03. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any qualified counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right, title or interest of the guarantee obligations: all accounts, all chattel paper; all deposit accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, Cayman Islands Branch (The Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second lien debenture
    Erstellt am 14. März 2006
    Geliefert am 03. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, Cayman Islands Branch (The Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Apr. 2005
    Geliefert am 03. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due, or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lehman Commercial Paper Inc (As Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 03. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Apr. 2005
    Geliefert am 03. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lehman Commercial Paper Inc (As Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 03. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Feb. 2002
    Geliefert am 14. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat INFOR GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Apr. 2019Beginn der Liquidation
    01. Juli 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Glyn Mummery
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praktiker
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Jeremy Stuart French
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praktiker
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0