UCI DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | UCI DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02090653 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
- Filmverleih (59131) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| UCI DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | 02. Mai 1989 | 02. Mai 1989 |
| CIC | 12. Jan. 1989 | 12. Jan. 1989 |
| AMC DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | 22. Apr. 1987 | 22. Apr. 1987 |
| GOLDENVISUAL LIMITED | 19. Jan. 1987 | 19. Jan. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX zum 1 More London Place London SE1 2AF am 06. Okt. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirsten Lawton als Sekretär am 18. Mai 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Brooks Rainer als Direktor am 18. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirsten Lawton als Sekretär am 18. Mai 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil James Williams als Geschäftsführer am 18. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Jonathan Way als Geschäftsführer am 18. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Stephen Alker als Geschäftsführer am 18. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Michael Donovan als Geschäftsführer am 30. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Kirsten Lawton am 04. Aug. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINER, John Brooks | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United States | American | 230136900001 | |||||
| FOX, Carol Collins | Sekretär | Lee House 90 Greay Bridgewater Street M1 5JW Manchester | British | 34028170003 | ||||||
| JAGANNATH, Vidya | Sekretär | 4 Caterham Avenue BL3 3RF Bolton Lancashire | British | 104920640001 | ||||||
| LAWTON, Kirsten | Sekretär | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | British | 50045660003 | ||||||
| MCDONAGH, John James | Sekretär | 6 Redesmere Close Timperley WA15 7EE Altrincham Cheshire | British | 38769610001 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Sekretär | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RICHARDS, James Timothy | Sekretär | 8a Marides Road Kensington W8 2LJ London | British | 30429210001 | ||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| ALKER, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 120642230001 | |||||
| DONOVAN, Paul Michael | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | England | British | 154988050002 | |||||
| GAVIN, Alexander Rupert | Geschäftsführer | Whitcomb Street WC2H 7DN London 54 | England | British | 16875680005 | |||||
| GOSLING, Steven Paul | Geschäftsführer | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 124301460001 | |||||
| HARRIS, Roger John | Geschäftsführer | Green Villa Park SK9 6EJ Wilmslow 14 Cheshire | United Kingdom | British | 129109390001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Geschäftsführer | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Geschäftsführer | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| RIBBONS, Justin Charles | Geschäftsführer | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Geschäftsführer | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| SINYOR, Joseph | Geschäftsführer | 70 Sheldon Avenue N6 4ND London | United Kingdom | British | 142528420002 | |||||
| WAY, Mark Jonathan | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 191239860001 | |||||
| WILLIAMS, Neil James | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 194329360001 | |||||
| ESSENTIAL CINEMAS BV | Geschäftsführer | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479600001 | |||||||
| UNITED CINEMAS INTERNATIONAL MULTIPLEX BV | Geschäftsführer | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479570001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS HOLDING III CORP | Geschäftsführer | 800 Third Avenue New York Ny 10022 Usa | 98626030001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV | Geschäftsführer | Hagedoornlaan 2 PO BOX 37267 FOREIGN Amsterdam 1030 Ag | 30239060004 | |||||||
| VIACOM INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV | Geschäftsführer | Naritaweg 207 1043 Cb Amsterdam The Netherlands | 37696370007 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Cinemas International (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat UCI DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security registered in scotland on 28/2/91 | Erstellt am 28. Feb. 1991 Geliefert am 11. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee terms of a personal bond dated 4TH & 10TH october 1990 | |
Kurze Angaben All & whole the tenants part of lease relating to all & whole that area of ground extending 0.640 hectares in the clydesbank district of strathclyde region forming part of phase 111 of the clyde shopping centre, title no dmb 22832. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 1989 Geliefert am 18. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Not exceeding £110,000,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of letter of credit, the overdraft facility and any relevant collateral dcoument (as defined) | |
Kurze Angaben (See doc M395 ref M263L for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental loan agreement | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 22. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £64,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Kurze Angaben Floating charge over (see doc M551C for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental loan agreement | Erstellt am 14. Sept. 1989 Geliefert am 19. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Kurze Angaben Floating charge over (see 395-tc no. 213 for further details). Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental loan agreement, | Erstellt am 16. Juni 1989 Geliefert am 03. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £48,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH december 1988 and this supplemental loan agreement | |
Kurze Angaben Floating charge over all the undertaking, property assets and rights (see for 395 relative to this charge ref m 568C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Loan agreement | Erstellt am 12. Dez. 1988 Geliefert am 28. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from amc entertainments (UK) limited and/or CIC multiplex cinemas B.V. to the chargee under the terms of the loan agreement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all the undertaking, property assets and rights (please refer to doc M395 ref M364 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat UCI DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0