KERSTONFELL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KERSTONFELL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 02092785 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KERSTONFELL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich KERSTONFELL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KERSTONFELL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STUART ROBB FUNERAL SERVICE LIMITED(THE) | 12. März 1987 | 12. März 1987 |
| KERSTONFELL LIMITED | 23. Jan. 1987 | 23. Jan. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KERSTONFELL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Jan. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KERSTONFELL LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für KERSTONFELL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Forms b & z - convert to i&ps | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Andrew Oldale als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Walker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hendry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hendry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr George Murray Tinning am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Buchan Hendry am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil James Walker am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Caroline Jane Sellers als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Eldridge als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 10. Jan. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 12. Jan. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KERSTONFELL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | 150154570001 | |||||||
| OLDALE, Andrew | Geschäftsführer | Brantingham Road Chorlton M21 0TS Manchester 15 United Kingdom | England | British | 167083200001 | |||||
| TINNING, George Murray | Geschäftsführer | c/o Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, Governance Department United Kingdom | United Kingdom | British | 126913730001 | |||||
| BEAUMONT, Martin Dudley | Sekretär | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | British | 10084840001 | ||||||
| BEWLEY, Bernard | Sekretär | 8 Ash Rise ST17 9HE Stafford Staffordshire | British | 2087640001 | ||||||
| ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Sekretär | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport | British | 110230860001 | ||||||
| JONES, Philip Robert | Sekretär | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | English | 43686960001 | ||||||
| KEW, Philip Anthony | Sekretär | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | British | 84868550001 | ||||||
| SALMONS, Raymond | Sekretär | Fox Hollow Sovereign Lane Ashley TF9 4LS Market Drayton Shropshire | British | 33031700001 | ||||||
| UCL SECRETARY LIMITED | Sekretär | United Co Operatives Limited Sandbrook Park Sandbrook Way OL11 1RY Rochdale Lancashire | 111685670001 | |||||||
| BEAUMONT, Martin Dudley | Geschäftsführer | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 10084840001 | |||||
| HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | c/o Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | Scotland | British | 128555100001 | |||||
| HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | Cardney Estate Butterstone PH8 0EY By Dunkeld Over Cardney Farmhouse Perthshire | Scotland | British | 128555100001 | |||||
| JONES, Philip Robert | Geschäftsführer | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | United Kingdom | English | 43686960001 | |||||
| KEW, Philip Anthony | Geschäftsführer | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | England | British | 84868550001 | |||||
| SALMONS, Raymond | Geschäftsführer | Fox Hollow Sovereign Lane Ashley TF9 4LS Market Drayton Shropshire | British | 33031700001 | ||||||
| THOMSON, John | Geschäftsführer | Five Oaks 56 Parkway Dairyfields Trentham ST4 8AG Stoke On Trent Staffordshire | British | 57103470001 | ||||||
| WALKER, Neil James | Geschäftsführer | c/o Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | England | British | 126913860001 | |||||
| WATES, Martyn James | Geschäftsführer | 3 Aylesby Close WA16 8AE Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 60114700001 | |||||
| UCL DIRECTOR 1 LIMITED | Geschäftsführer | United Co-Operatives Limited Sandbrook Park OL11 1RY Rochdale | 110868260001 |
Hat KERSTONFELL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 12. Aug. 1987 Geliefert am 19. Aug. 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Juli 1987 Geliefert am 20. Juli 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 60 the hill sandbach cheshire and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Juli 1987 Geliefert am 20. Juli 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a "laburnam cottage" 17 macclesfield road, holmes, chapel cheshire and the proceeds of sale thereof of together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Juni 1987 Geliefert am 22. Juni 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a plot of land adjoining antrobus street, congleton cheshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Juni 1987 Geliefert am 22. Juni 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 12 hospital street, crewe and nantwich cheshire T.N. ch 235614 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Juni 1987 Geliefert am 22. Juni 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 93 antrobus street, congleton, cheshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Juni 1987 Geliefert am 22. Juni 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north easterly side of love lane crewe and nantwich cheshire T.N. ch 103939 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0