OPAL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOPAL DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02093763
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OPAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich OPAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für OPAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    47 SeitenWU15

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    47 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    45 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    44 SeitenWU07

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY zum 2 st Peters Square Manchester M2 3EY am 09. Aug. 2017

    2 SeitenAD01

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack
    42 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:progress report brought down to 24/02/16
    41 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015
    42 SeitenLIQ MISC

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    53 Seiten2.33B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Jan. 2014

    46 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Sept. 2013

    62 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    117 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    5 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP am 18. März 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    19 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Aug. 2012

    Kapitalaufstellung am 02. Aug. 2012

    • Kapital: GBP 500,000
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von OPAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Sekretär
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Geschäftsführer
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Geschäftsführer
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    BONNEY, Joyce Elizabeth
    40 Hyde Bank Road
    New Mills
    SK22 4NN High Peak
    Derbyshire
    Sekretär
    40 Hyde Bank Road
    New Mills
    SK22 4NN High Peak
    Derbyshire
    British73607970001
    WALL, Mary Annice
    2 Deneford Road
    Didsbury
    Manchester
    Sekretär
    2 Deneford Road
    Didsbury
    Manchester
    British30065270002
    BONNEY, Joyce Elizabeth
    40 Hyde Bank Road
    New Mills
    SK22 4NN High Peak
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    40 Hyde Bank Road
    New Mills
    SK22 4NN High Peak
    Derbyshire
    British73607970001
    HANSON, James Donald
    18 Thurloe Place
    SW7 2SP London
    Geschäftsführer
    18 Thurloe Place
    SW7 2SP London
    British45201690007
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    WALL, Mary Annice
    2 Deneford Road
    Didsbury
    Manchester
    Geschäftsführer
    2 Deneford Road
    Didsbury
    Manchester
    British30065270002

    Hat OPAL DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Mai 2005
    Geliefert am 28. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    15 ladybarn road fallowfield manchester t/no la 119122, 25 and 25A ladybarn road fallowfield manchester t/no LA118860, opal court mosley road fallowfield manchester t/no gm 676966 and opal house 11 whitworth street manchester t/no la 373141. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 2002
    Geliefert am 24. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first legal mortgage all estates or interests of the chargor in any f/h or l/h property including the f/h land on the north side of hope road manchester t/n GM888423, the l/h land on the north east side victoria park manchester t/n LA42406, the f/h land being wyncote hope road victoria park rusholme t/n LA81811 for details of further properties charged please see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties(The Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 24. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge
    Erstellt am 05. Juli 2000
    Geliefert am 14. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Property namely opal gardens anson road victoria park manchester t/nos: LA69837 GM295335 LA87192 LA96836 LA4206 and LA81811.
    Berechtigte Personen
    • Creditforce Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 05. Juli 2000
    Geliefert am 14. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    The property namely opal house 11 whitworth street manchester t/no: LA373141.
    Berechtigte Personen
    • Creditforce Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 05. Juli 2000
    Geliefert am 14. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    The property namely opal court mosley road manchester t/no: GM676966.
    Berechtigte Personen
    • Creditforce Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 27. Nov. 1997
    Geliefert am 09. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and arising in respect of a building agreement dated 10 november 1997 between the company and l brown and sons limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Nov. 1997
    Geliefert am 20. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a land on the south side of daisy bank road, victoria road; f/h property k/a land lying to the north of anson road victoria park; t/no:GM295335; l/h property k/a land on the west side of wyncote hope road victoria parkt/no:LA87192 .. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 08. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that agreement made 15TH january 1997 made between the comany and l brown and sons LTD.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 08. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Nov. 1996
    Geliefert am 20. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 11 whitworth street manchester t/no LA373141. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment and charge
    Erstellt am 31. Dez. 1995
    Geliefert am 06. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The benefit of all agreement and all rights title and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Okt. 1995
    Geliefert am 23. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15 ladybarn road fallowfield t/n-LA119122 and 25/25A ladybarn road, fallowfield t/n-LA1188860 and land and premises in mosely road fallowfield t/n-GM676966. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 1993
    Geliefert am 29. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 25 & 25A ladybarn road fallowfield manchester t/no la 119122 with fixtures buildings plant & machinery & the goodwill of the business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 1993
    Geliefert am 29. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 15 ladybarn road fallowfield manchester t/no LA118860 with buildings & fixtures plant & machinery & the goodwill of the business & the benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 14. Okt. 1988
    Geliefert am 20. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to two legal charges dated 14/06/88
    Kurze Angaben
    Rental income due at any time in connection with the leases hereinafter mentioned at no. 15 ladybarn rod (please sea form 395 for list of tenants.) no 25 & 25A ladybarn road (please see form 395 for list of tenants).
    Berechtigte Personen
    • Aktiesels Kabet Kjobenhavns Handelsbanken
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. Juni 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Okt. 1988
    Geliefert am 20. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 15 ladybarn road fallowfield manchester T.no.la.118860 F/h land k/a 25 & 25A ladybarn road fallowfield manchester T.no. La 119122 together with all fixtures & fittings whatsoever.
    Berechtigte Personen
    • Aktiesels Kabet Kjobenhavns Handels Bank
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. Juni 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juli 1987
    Geliefert am 23. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property in the county of greater manchester in the district of stockport k/a 36 brook street, cheadle title no gm 65146 together with all fixtures & fittings.
    Berechtigte Personen
    • Aktiesels Kabet Kjobenhavns Handelsbank Otherwise Known as Copenhagen Handelsbank a/S
    Transaktionen
    • 23. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 14. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat OPAL DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. März 2013Beginn der Verwaltung
    25. Feb. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    DatumTyp
    13. Sept. 2019Abschluss der Liquidation
    10. Feb. 2014Antragsdatum
    25. Feb. 2014Beginn der Liquidation
    20. Feb. 2020Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    Praktiker
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0