SUPERGLASS SECTIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SUPERGLASS SECTIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02095397 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUPERGLASS SECTIONS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich SUPERGLASS SECTIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading Berkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUPERGLASS SECTIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SELECTUSUAL LIMITED | 02. Feb. 1987 | 02. Feb. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPERGLASS SECTIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUPERGLASS SECTIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Sept. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Webster als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Robert Andrew Ross Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Paul Webster am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alison Drew am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 403a | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von SUPERGLASS SECTIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREW, Alison | Sekretär | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading Berkshire | British | 86845230002 | ||||||
SMITH, Robert Andrew Ross | Geschäftsführer | Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading Parkview 1220 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 150753930001 | ||||
WOLSELEY DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Parkview 1220 Arlington Business Park, Theale RG7 4GA Reading | 122185200001 | |||||||
BILSLAND, Nicol Muir | Sekretär | 17 Westcliffe Grove HG2 0PS Harrogate North Yorkshire | British | 37691300001 | ||||||
KIRK, Philip Anthony | Sekretär | 8 Ullswater Rise LS22 6YP Wetherby West Yorkshire | British | Company Director | 35144620001 | |||||
BILSLAND, Nicol Muir | Geschäftsführer | 17 Westcliffe Grove HG2 0PS Harrogate North Yorkshire | British | Company Director | 37691300001 | |||||
CREIGHTON, David Marshall | Geschäftsführer | Ardarroch Western Road PH3 1JJ Auchterader Perthshire | British | Company Director | 6387090001 | |||||
GEDDES, James Lobban | Geschäftsführer | 48 Kenilworth Road Bridge Of Allan FK9 4RP Stirling Stirlingshire | British | Company Director | 37338950001 | |||||
KIRK, Philip Anthony | Geschäftsführer | 8 Ullswater Rise LS22 6YP Wetherby West Yorkshire | British | Company Director/Secretary | 35144620001 | |||||
KIRKBRIGHT, Anthony | Geschäftsführer | 12 Wedderburn Road FK15 0FN Dunblane Perthshire | Scotland | British | Company Director | 107324880001 | ||||
MCKERRACHER, Iain Douglas | Geschäftsführer | 13a Kent Road HG1 2LE Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 692370001 | ||||
PATERSON, Robert | Geschäftsführer | 7 Beech Crescent Braco FK15 9RG Dunblane Perthshire | Scotland | British | Company Director | 57169500001 | ||||
PATERSON, Robert | Geschäftsführer | 7 Beech Crescent SK15 9RG Braco Perthshire | British | Company Director | 28178550001 | |||||
SEITZ, Wilfried | Geschäftsführer | 6238 Hofheim-Wallau West Germany | German | Company Director | 28170840001 | |||||
SMELLIE, John | Geschäftsführer | 3 Millbrae Gargunnock FK8 3BB Stirling | Scotland | British | Company Director | 6427660001 | ||||
WEBSTER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 40201730005 | ||||
WHITE, Mark Jonathan | Geschäftsführer | Hawthorn House 2 Wards Drive, Sarratt WD3 6AE Rickmansworth Herts | England | British | Solicitor | 82978250002 |
Hat SUPERGLASS SECTIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 23. Juli 1999 Geliefert am 31. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities now or at any time hereafter due or owing from the company to the chargee (acting for itself and on behalf of the investors) and to the investors (as defined) or any of them pursuant to the deed of guarantee of even date | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Nov. 1997 Geliefert am 29. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due owing or incurred from the company to 3I PLC for itself and as trustee for the investors (as defined in the charge) and to any of the investors pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date with the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 20. Nov. 1997 Geliefert am 28. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents | |
Kurze Angaben L/H land k/a 6A and 6B tweed road clevedon t/no AV54465 l/h land k/a unit B2 knights park strood t/no K67267 l/h land k/a units 17, 18, 19 bloorsgrove estate ilkeston road nottingham t/no NT48699 for further details of property charged please refer to form 395 'the first schedule'. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Okt. 1987 Geliefert am 23. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0