NATIONAL HOLIDAYS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NATIONAL HOLIDAYS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02100628 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NATIONAL HOLIDAYS LIMITED?
- Sonstiger Personenlandverkehr im Stadt-, Vorort- oder Ballungsraum (nicht U-Bahn, Metro oder ähnlich) (49319) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich NATIONAL HOLIDAYS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Ernst & Young Llp 2 St. Peters Square M2 3EY Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NATIONAL HOLIDAYS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
NATIONAL HOLIDAYS COACHES LIMITED | 20. Aug. 1999 | 20. Aug. 1999 |
NATIONAL HOLIDAYS LIMITED | 03. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 |
EAST YORKSHIRE TRAVEL LIMITED | 07. Dez. 1992 | 07. Dez. 1992 |
CHERRY COACHES LIMITED | 17. Feb. 1987 | 17. Feb. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NATIONAL HOLIDAYS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NATIONAL HOLIDAYS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 41 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 40 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 41 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 41 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 43 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Beendigung der Bestellung von Martin Stuart Lock als Geschäftsführer am 02. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 49 Seiten | AM10 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard James Calvert als Geschäftsführer am 29. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul David Smith als Geschäftsführer am 17. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 4 Seiten | AM06 | ||
Vorschlag des Verwalters | 90 Seiten | AM03 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 11 Seiten | AM02 | ||
Beendigung der Bestellung von a G Secretarial Limited als Sekretär am 22. März 2020 | 2 Seiten | TM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom zum C/O Ernst & Young Llp 2 st. Peters Square Manchester M2 3EY am 10. Juni 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 25 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gary Speakman als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Paul David Smith als Direktor am 01. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Vincent Flower als Geschäftsführer am 01. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 22 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Graham John Rogers am 12. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von NATIONAL HOLIDAYS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGERS, Graham John | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69494710002 | ||||||||
BUTTERWORTH, Peter | Sekretär | 5 Beech Grove HU13 0LJ Hessle East Yorkshire | British | 77262180001 | ||||||||||
COOKE, Andrew Charles | Sekretär | 22 Orchard Close DN19 7DT Barrow Upon Humber South Humberside | British | 11526650001 | ||||||||||
HINSLIFF, Robert | Sekretär | 30 Buckingham Drive WA16 8LH Knutsford Cheshire | British | 51000070001 | ||||||||||
LEEMAN, Paul Arthur | Sekretär | 48 Sunningdale Road HU13 9BW Hessle North Humberside | British | 31184750001 | ||||||||||
THOMAS, Joan Valerie | Sekretär | 3 Broom Road LS24 9LH Tadcaster North Yorkshire | British | 51418740001 | ||||||||||
TURNER, Jayne Marie | Sekretär | 33 Dingleway Appleton WA4 3AB Warrington Cheshire | British | Accountant | 117561640001 | |||||||||
WORSNUP, Peter Jonathan | Sekretär | 12 Grantley Place Bradley HD2 1LZ Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 95865490001 | |||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
BARBER, Stephen Donald | Geschäftsführer | 5 Springbank Close Farsley Pudsey LS28 5TP Leeds West Yorkshire | British | Director | 11617040001 | |||||||||
BURKE, Jane Bain | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 51003380001 | ||||||||
BURLEY, Brian Godfrey | Geschäftsführer | 6 Styles Croft Swanland HU14 3NU North Ferriby East Yorkshire | England | British | Chairman | 11526660002 | ||||||||
BURLEY, Brian Godfrey | Geschäftsführer | 6 Styles Croft Swanland HU14 3NU North Ferriby East Yorkshire | England | British | Chartered Accountant And Manag | 11526660002 | ||||||||
BURLEY, Helen Wood | Geschäftsführer | 6 Styles Croft Swanland HU14 3NU North Ferriby East Yorkshire | British | Housewife | 12560040002 | |||||||||
BUTTERWORTH, Peter | Geschäftsführer | 5 Beech Grove HU13 0LJ Hessle East Yorkshire | British | Director | 77262180001 | |||||||||
CALVERT, Richard James | Geschäftsführer | 2 St. Peters Square M2 3EY Manchester C/O Ernst & Young Llp | England | British | Ceo | 163434180002 | ||||||||
FLOWER, Vincent | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 91542970002 | ||||||||
FREEMAN, Paul Stephen | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | British | Accountant | 52600500001 | |||||||||
HARRISON, Clare Louise | Geschäftsführer | 39 Spindlewood Elloughton HU15 1LL Brough North Humberside | British | Director | 65873720001 | |||||||||
KING, James Hughie | Geschäftsführer | 2 Lumbrook Close Coley HX3 7UD Halifax West Yorkshire | British | Company Director | 51002070003 | |||||||||
LEWIS, Rachael Anne | Geschäftsführer | 21 Dunston Drive HU13 0HF Hessle North Humberside | British | Director | 65873890001 | |||||||||
LEWIS, Steven Martin | Geschäftsführer | 21 Dunston Drive HU13 0HF Hessle East Yorkshire | British | Director | 65873490001 | |||||||||
LOCK, Martin Stuart | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 138681500002 | ||||||||
MAXWELL, William | Geschäftsführer | Snelsins House Snelsins Lane BD19 3UE Cleckheaton West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 108831380001 | ||||||||
MEDDES, Kenneth Sydney | Geschäftsführer | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | United Kingdom | British | Director | 11486330002 | ||||||||
NEWBOLD, David Robert | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 30276880001 | ||||||||
O'CALLAGHAN, Joseph | Geschäftsführer | 9 Mallard Walk DE3 0TF Derby Derbyshire | England | British | Director | 110216340001 | ||||||||
ROGERS, Graham John | Geschäftsführer | 21 Grundale Anlaby HU10 7LA Hull North Humberside | United Kingdom | British | Managing Director | 69494710001 | ||||||||
SHIPP, Peter John Sidney | Geschäftsführer | Church Farm 25 Church Street Elloughton HU15 1HT Brough | England | British | Managing Director | 39074740001 | ||||||||
SLATCHER, David John | Geschäftsführer | 3 Brindle Heights Water Street Brindle PR6 8YA Chorley Lancashire | British | Comapny Director | 104434750001 | |||||||||
SMITH, Paul David | Geschäftsführer | Waterside Drive Wigan Pier Business Park WN3 5AZ Wigan C/O Specialist Leisure Group, Waterside House United Kingdom | England | British | Accountant | 228581750001 | ||||||||
SPEAKMAN, Gary | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Finance Director | 56066860001 | ||||||||
WORMWELL, Denis | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 124681340001 | ||||||||
WORSNUP, Peter Jonathan | Geschäftsführer | 12 Grantley Place Bradley HD2 1LZ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 95865490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NATIONAL HOLIDAYS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Holidays Tours Limited | 06. Apr. 2016 | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat NATIONAL HOLIDAYS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and set-off agreement | Erstellt am 20. Apr. 2006 Geliefert am 05. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its credit balances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Apr. 2006 Geliefert am 05. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 30. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite cross guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 02. Okt. 2001 Geliefert am 18. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 22. Juni 1998 Geliefert am 29. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of bonded coach holidays for £2,500,000 | |
Kurze Angaben The sum of £600,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 10306595 and earmarked by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 16. Sept. 1997 Geliefert am 22. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 03. Jan. 1997 Geliefert am 04. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £675,000 and all other moneys due from the company formerly known as east yorkshire travel limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben A first fixed charge over coaches (X15) 1989 leyland tiger paramount 1989 leyland tiger paramount regn no's F349 jat & 665 eyl. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat NATIONAL HOLIDAYS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0