ELEGANT RESORTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ELEGANT RESORTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02100913 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELEGANT RESORTS LIMITED?
- Reisebüroaktivitäten (79110) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
- Aktivitäten von Reiseveranstaltern (79120) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich ELEGANT RESORTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Elegant House Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELEGANT RESORTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LEMONSHORES LIMITED | 18. Feb. 1987 | 18. Feb. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELEGANT RESORTS LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ELEGANT RESORTS LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 27. März 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 10. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 27. März 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ELEGANT RESORTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||
Ernennung von Mr Alwaleed Alnasser als Direktor am 30. Sept. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Muzzammil Ahussain als Direktor am 30. Sept. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Muhammad Khalid als Direktor am 30. Sept. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 48 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 42 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Abdullah Al Darwood am 11. Apr. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 33 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 36 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Yousif Musa Yousif als Geschäftsführer am 30. Juli 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 37 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 39 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Portman Travel Group Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 35 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Portman Travel Group Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Beendigung der Bestellung von Michelle Julie Sephton als Geschäftsführer am 10. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Cessation of Nasser Aqueel Altayyar as a person with significant control on 01. Jan. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Ernennung von Mr Redmond Gavin Mcginty Walsh als Direktor am 20. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ELEGANT RESORTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHUSSAIN, Muzzammil | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House | United Arab Emirates | American | Chief Executive Officer | 328102360001 | ||||||||
ALDAWOOD, Abdullah | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House | Saudi Arabia | Saudi Arabian | Company Director | 203779690002 | ||||||||
ALNASSER, Alwaleed | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House | Saudi Arabia | Saudi Arabian | Ceo | 327714200001 | ||||||||
KHALID, Muhammad, Mr. | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House | England | Pakistani | Director | 315430690001 | ||||||||
NEVIN, Mark Christopher | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House | England | British | Company Director | 103941850001 | ||||||||
WALSH, Redmond Gavin Mcginty | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House | Northern Ireland | British | Company Director | 209878750001 | ||||||||
ATKINSON, Paul | Sekretär | The Hurst Kingsley WA6 8AU Frodsham Orchard End Cheshire | British | Chartered Accountant | 131682480001 | |||||||||
BRADLEY, Shirley | Sekretär | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | 158801810001 | |||||||||||
HALLISEY, David Michael William | Sekretär | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | British | 1919030001 | ||||||||||
MOSS, Geoffrey Philip | Sekretär | Sibbersfield Hall Farm Sibbersfield Lane Churton CH3 6LQ Chester Cheshire | British | 1498950001 | ||||||||||
AIRD-MASH, Phillip John | Geschäftsführer | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | United Kingdom | British | Company Director | 163165700002 | ||||||||
AL TAYYAR, Nasser Aqeel, Dr | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House England | Kingdom Of Saudi Arabia | Saudi Arabian | Director | 183972940001 | ||||||||
ATKINSON, Paul | Geschäftsführer | The Hurst Kingsley WA6 8AU Frodsham Orchard End Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 131682480001 | ||||||||
BUESER, Juergen, Dr. | Geschäftsführer | Panton Street CB2 1HP Cambridge 30 Cambs United Kingdom | German | Company Director | 115249060004 | |||||||||
CATCHPOLE, Barbara | Geschäftsführer | Old Pump Cottage Pump Lane Churton CH3 6LR Chester Cheshire | England | British | Tour Operator | 18999840002 | ||||||||
DERBYSHIRE, Ian Richard, Mr. | Geschäftsführer | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | United Kingdom | British | Company Director | 127988300001 | ||||||||
FONTENLA-NOVOA, Manny | Geschäftsführer | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | British | Company Director | 127990200002 | |||||||||
GADSBY, Christopher James | Geschäftsführer | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | England | British | Company Director | 118396090002 | ||||||||
LLOYD, Sharon Ann | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House England | United Kingdom | British | Company Director | 176707170001 | ||||||||
MOHAMMED, Ali Altagani Ahmed, Dr | Geschäftsführer | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | Kingdom Of Saudi Arabia | Sudanese | Director | 186082990001 | ||||||||
MOHAMMED, All Altagani Ahmed, Dr | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House England | Kingdom Of Saudi Arabia | Sudanese | Director | 185293400001 | ||||||||
MOSS, Geoffrey Philip | Geschäftsführer | Sibbersfield Hall Farm Sibbersfield Lane Churton CH3 6LQ Chester Cheshire | England | British | Tour Operator | 1498950001 | ||||||||
SEPHTON, Michelle Julie | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House England | United Kingdom | British | Company Director | 116547010001 | ||||||||
TAYLOR, David Michael | Geschäftsführer | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | England | British | Cfo Uk&I | 87424420002 | ||||||||
THOMSON, Ian Peter | Geschäftsführer | 1 The Limes Chester Road Rossett LL12 0DB Wrexham | United Kingdom | British | Consultant | 85707430001 | ||||||||
YOUSIF, Yousif Musa | Geschäftsführer | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House England | Saudi Arabia | American | Director | 183972960001 | ||||||||
YOUSIF, Yousif Musa | Geschäftsführer | Chester CH1 1RB Cheshire The Old Palace | Saudi Arabia | American | Director | 183972960001 | ||||||||
THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs United Kingdom |
| 146474110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ELEGANT RESORTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nasser Aqueel Altayyar | 06. Apr. 2016 | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House | Ja | ||||||||||
Nationalität: Saudi Arabian Staatsangehörigkeit: Kingdom Of Saudi Arabia | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Portman Travel Group Limited | 06. Apr. 2016 | Sandpiper Way Chester Business Park CH4 9QE Chester Elegant House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ELEGANT RESORTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge of deposit | Erstellt am 31. Okt. 2002 Geliefert am 07. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 10452397 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 18. Sept. 2001 Geliefert am 28. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation no 8650403 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 18. Sept. 2000 Geliefert am 22. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the civil aviation authority for £5,800,000 | |
Kurze Angaben The sum of £1,918,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8650403 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 23. März 2000 Geliefert am 31. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the civil aviation authority for £5,000,000 | |
Kurze Angaben The sum of £1,225,000 with interest accrued to be held by the bank on account number 8650403 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 21. Sept. 1999 Geliefert am 28. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of civil aviation authority for £4,855,000 | |
Kurze Angaben The sum of £1,268,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8650403 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 25. Sept. 1998 Geliefert am 05. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sum of £577,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 23161027 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 29. Juni 1998 Geliefert am 03. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sum of £217,750 together with interest accrued now or to be held by the bank on account numbered 23161027 and earmarked or designated in the name of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 02. Feb. 1998 Geliefert am 06. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of the civil aviation authority for £1,500,000 | |
Kurze Angaben The sum of £217,750 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 23161027 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 23. Sept. 1997 Geliefert am 30. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of civil aviation authority for £1,500,000 | |
Kurze Angaben The sum of £300,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 23161027 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 17. März 1997 Geliefert am 24. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee dated 12 september 1996 in favour of the civil aviation authority for £1,000,000 | |
Kurze Angaben The sum of £179,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 23161027 and earmarked by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 19. Dez. 1996 Geliefert am 30. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 12TH september 1996 in favour of the civil aviation authority for £1,000,000 | |
Kurze Angaben The sum of £326,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 23161027 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 13. Sept. 1996 Geliefert am 27. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to guarantee dated 12TH september 1996 in favour of the civil aviation authority for £1,000,000 | |
Kurze Angaben The sum of £480,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 23161027. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of charge | Erstellt am 17. Okt. 1994 Geliefert am 20. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys standing to the credit of the premier investment account of the company in the banks books numbered 01924195. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0