KEARS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KEARS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02101165 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KEARS GROUP LIMITED?
- Aktivitäten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften (99000) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich KEARS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KEARS GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RJT 62 LIMITED | 18. Feb. 1987 | 18. Feb. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KEARS GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KEARS GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für KEARS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Greencore Group Uk Centre Midland Way Barlborough Links Business Park Barlborough Chesterfield S43 4XA zum Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD am 22. Mai 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 9 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Juni 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diane Walker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Sept. 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms. Jolene Anna Gacquin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Coveney als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Sept. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Barratt als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Diane Walker als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KEARS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLEARY, Conor | Sekretär | Carrigabruce Enniscorthy Ard Na Laoi Co Wexford Ireland | British | 151166570001 | ||||||
| EVANS, Michael | Geschäftsführer | Midland Way Barlborough Links Business Park S43 4XA Barlborough Uk Centre Chesterfield United Kingdom | United Kingdom | British | 148060720001 | |||||
| GACQUIN, Jolene Anna, Ms. | Geschäftsführer | c/o Greencore Group Plc Northwood Avenue Northwood Business Park Santry No 2 Dublin9 Ireland | Ireland | Irish | 176849210001 | |||||
| O'LEARY, Conor | Geschäftsführer | Carrigabruce Enniscorthy Ard Na Laoi Co Wexford Ireland | Ireland | Irish | 143778250002 | |||||
| ODLUM, Philip Edwin | Geschäftsführer | 109 Anglesea Road IRISH Ballisbridge Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | 144667960001 | |||||
| WILLIAMS, Alan Richard, Mr. | Geschäftsführer | 2 Northwood Avenue Northwood Business Park 9 Santry Greencore Group Plc Dublin Ireland | England | British | 137582690001 | |||||
| BELL, David Anthony | Sekretär | 49 Hollybank Avenue Lower IRISH Rathgar Dublin 6 Republic Of Ireland | Irish | 89468330001 | ||||||
| HATCHER, Mark Jon | Sekretär | Elmleigh Wainlode Lane GL2 9LN Norton Gloucestershire | British | 9437690002 | ||||||
| BARRATT, William Harrison | Geschäftsführer | 3 Sycamore Close DN22 7JP Retford Nottinghamshire | England | British | 100531360001 | |||||
| BERGIN, Caroline Margaret | Geschäftsführer | 8 Holyrood Park Sandymount Dublin 4 Dublin 4 Republic Of Ireland | Ireland | Irish | 89332200002 | |||||
| COVENEY, Patrick Francis | Geschäftsführer | 6 Leinster Square Rathmines IRISH Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | 143778240001 | |||||
| DILGER, David John | Geschäftsführer | Lauriston Cenacle Grove Killiney Hill Road Killiney Co Dublin Ireland | Irish | 74455510001 | ||||||
| ELSMORE, Brenda Jean | Geschäftsführer | The Hermitage Staunton GL16 8NY Coleford Gloucestershire | England | British | 27571940002 | |||||
| GARAVAN, Charles | Geschäftsführer | Curragrean Oranmore IRISH Co Galway Republic Of Ireland | Irish | 9725560001 | ||||||
| HATCHER, Mark Jon | Geschäftsführer | Elmleigh Wainlode Lane GL2 9LN Norton Gloucestershire | United Kingdom | British | 9437690002 | |||||
| HYNES, Anthony Martin | Geschäftsführer | The Piggeries Hassop DE45 1NW Bakewell Derbyshire | England | Irish | 100467690002 | |||||
| KEAR, Harry James | Geschäftsführer | The Hollies Church Road Clearwell GL16 8QT Coleford Gloucestershire | United Kingdom | British | 8126880001 | |||||
| KEAR, Ronald | Geschäftsführer | Indra House Chepstow Road NP5 2EN Raglan Gwent | British | 9319170001 | ||||||
| KENNEDY, Patrick Thomas | Geschäftsführer | 61 Dartmouth Square Dublin 6 Ireland | Irish | 74455540001 | ||||||
| KNIGHT, Vivian Robert | Geschäftsführer | Hollymead House Smithers Cross GL17 9TT Ruardean Gloucestershire | British | 27522440001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Kevin Clive | Geschäftsführer | 17 Elgin Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | British | 3562130002 | ||||||
| ODLUM, Philip Edwin | Geschäftsführer | 109 Anglesea Road IRISH Ballisbridge Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | 144667960001 | |||||
| POWER, Benjamin John | Geschäftsführer | The Moorings Church Road IRISH Killiney County Dublin Ireland | Irish | 45422850002 | ||||||
| SMITH, Gerard Arthur | Geschäftsführer | 158 Bawtry Road Bassacarr DN4 7BT Doncaster South Yorkshire | England | British | 111889550001 | |||||
| TAYLOR, Philip John | Geschäftsführer | Orchard House Main Road WR2 6PW Ombersley Worcestershire | British | 105805650001 | ||||||
| TRUELOVE, Amelia Anne | Geschäftsführer | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | 37845970003 | ||||||
| WALKER, Diane Susan | Geschäftsführer | Manton Wood Enterprise Park Retford Road S80 2RS Worksop Greencore Food To Go Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 156683540001 | |||||
| YEATES, Paul | Geschäftsführer | 10 Belle Baulk NN12 6YH Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 71252220001 |
Hat KEARS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Single debenture | Erstellt am 10. Nov. 1994 Geliefert am 28. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 10. Nov. 1994 Geliefert am 28. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a claremont house and the bakery yorkley lydney gloucester t/no.GR151773 and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral floating charge | Erstellt am 16. Jan. 1992 Geliefert am 20. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from starbake yorkshire limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Mai 1991 Geliefert am 03. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H, the bakery, rogerstone, newport, gwent title no wa 239100. assigns goodwill (if any) (see form 395 and continuation sheets relevant to this charge).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Apr. 1989 Geliefert am 25. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the bakery, rogerstone, gwent title no wa 239100 assigns goodwill (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 17. Dez. 1987 Geliefert am 23. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Inc: all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat KEARS GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0