MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02103601 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Halesfield 2 TF7 4QH Telford Shropshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TRADESOURCE LIMITED | 25. Sept. 1987 | 25. Sept. 1987 |
ASTHALL PRINTING LIMITED | 25. Feb. 1987 | 25. Feb. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Lee Roberts am 13. Feb. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Antony James Banks am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Lee Roberts am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Martin Reid am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Rigby am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alan David Griffiths am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mail Solutions Stafford Park 9 Telford Shropshire TF3 3BZ am 29. Sept. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Edward Prescott am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Philip Martin Reid am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Robert Souster am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Lee Roberts am 15. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Philip Martin Reid am 15. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Rigby am 15. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Antony James Banks am 15. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REID, Philip Martin | Sekretär | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | British | Director | 57277220001 | |||||
BANKS, Antony James | Geschäftsführer | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | British | Director | 99144280001 | |||||
GRIFFITHS, Alan David | Geschäftsführer | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 35303410004 | ||||
PRESCOTT, Simon Edward | Geschäftsführer | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 72479260002 | ||||
REID, Philip Martin | Geschäftsführer | Halesfield 2 TF7 4QH Telford Shropshire United Kingdom | England | British | Accountant | 57277220001 | ||||
RIGBY, Paul | Geschäftsführer | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 122741700001 | ||||
ROBERTS, Lee | Geschäftsführer | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 50789080003 | ||||
SOUSTER, Mark Robert | Geschäftsführer | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | British | Director | 50789040003 | |||||
BANKS, Antony James | Sekretär | Bramblings High Street PE16 0LT Upper Dean Huntingdon | British | 99144280001 | ||||||
HUTCHERSON, John Michael | Sekretär | 21 Lancaster Close Wollaston NN29 7PD Wellingborough Northamptonshire | British | 10898310001 | ||||||
MAUGHAN, Anna | Sekretär | 404 Chester Road Boldmere B73 5BS Sutton Coldfield | British | 53071850001 | ||||||
PAGE, Adrian Peter | Sekretär | 11 Shadows Lane Congerstone CV13 6NF Nuneaton Warwickshire | British | Chartered Accountant | 50576960001 | |||||
STACEY, Alan Edward | Sekretär | 28 Edinburgh Close LE16 7QQ Market Harborough Leicestershire | British | Accountant | 50789190001 | |||||
BERTRAM, Andrew Stuart | Geschäftsführer | 46 Kings Lane Little Harrowden NN9 5BL Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 96094060001 | |||||
HUTCHERSON, John Michael | Geschäftsführer | 21 Lancaster Close Wollaston NN29 7PD Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 10898310001 | |||||
IRVING, John Leslie | Geschäftsführer | 3-5 North Street NN7 3JB Rothersthorpe Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 10898330001 | ||||
KIPLING, Neil William Stuart | Geschäftsführer | 15 The Downs NN9 5YP Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 10898340002 | |||||
PAGE, Adrian Peter | Geschäftsführer | 11 Shadows Lane Congerstone CV13 6NF Nuneaton Warwickshire | British | Chartered Accountant | 50576960001 | |||||
PENNA, David Malcolm | Geschäftsführer | 49 Borrowcop Lane WS14 9DG Lichfield Staffordshire | British | Director | 14573060001 | |||||
SHERMAN, Christopher Robert | Geschäftsführer | Elm Cottage City Corner, Hinton Parva SN4 0DH Swindon | British | Director | 83550360003 | |||||
STACEY, Alan Edward | Geschäftsführer | 28 Edinburgh Close LE16 7QQ Market Harborough Leicestershire | British | Accountant | 50789190001 | |||||
WHITTY, Brian Howard | Geschäftsführer | Ruxley House Rowney Green Lane Rowney Green B48 7QF Alvechurch Worcestershire | British | Financial Accountant | 36622750002 |
Hat MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 16. Apr. 2007 Geliefert am 21. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Juli 2004 Geliefert am 27. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 06. Mai 1997 Geliefert am 19. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys due or owing from time to time owing to the company under or by virtue of the contract(s) being trade indemnity PLC credit insurance policy number 100117201 together with the benefit of all securities for the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 19. Dez. 1996 Geliefert am 24. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and kelexcel limited to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 24. Feb. 1988 Geliefert am 29. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of assignment of the timson 2 colour T24 business forms press serial no 18711 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Feb. 1988 Geliefert am 11. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 18. Jan. 1988 Geliefert am 20. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of assignment of timson two colour T24 business forms press serial no 18710 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of deposit account moneys | Erstellt am 21. Dez. 1987 Geliefert am 29. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assignment of the sum of £250,000 or such sum or part thereof as is for the time being standing to the credit of the deposit account with investors in industry group PLC (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Dez. 1987 Geliefert am 29. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0