MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED

MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02103601
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Halesfield 2
    TF7 4QH Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRADESOURCE LIMITED25. Sept. 198725. Sept. 1987
    ASTHALL PRINTING LIMITED25. Feb. 198725. Feb. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Apr. 2013

    Kapitalaufstellung am 09. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 51,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Lee Roberts am 13. Feb. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    10 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    10 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Antony James Banks am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Lee Roberts am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Martin Reid am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Paul Rigby am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Alan David Griffiths am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mail Solutions Stafford Park 9 Telford Shropshire TF3 3BZ am 29. Sept. 2011

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Edward Prescott am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Philip Martin Reid am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mark Robert Souster am 29. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Lee Roberts am 15. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Philip Martin Reid am 15. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Paul Rigby am 15. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Antony James Banks am 15. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REID, Philip Martin
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Sekretär
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    BritishDirector57277220001
    BANKS, Antony James
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    BritishDirector99144280001
    GRIFFITHS, Alan David
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector35303410004
    PRESCOTT, Simon Edward
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector72479260002
    REID, Philip Martin
    Halesfield 2
    TF7 4QH Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Halesfield 2
    TF7 4QH Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant57277220001
    RIGBY, Paul
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector122741700001
    ROBERTS, Lee
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector50789080003
    SOUSTER, Mark Robert
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    BritishDirector50789040003
    BANKS, Antony James
    Bramblings
    High Street
    PE16 0LT Upper Dean
    Huntingdon
    Sekretär
    Bramblings
    High Street
    PE16 0LT Upper Dean
    Huntingdon
    British99144280001
    HUTCHERSON, John Michael
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    Sekretär
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    British10898310001
    MAUGHAN, Anna
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    Sekretär
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    British53071850001
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Sekretär
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    STACEY, Alan Edward
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant50789190001
    BERTRAM, Andrew Stuart
    46 Kings Lane
    Little Harrowden
    NN9 5BL Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    46 Kings Lane
    Little Harrowden
    NN9 5BL Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector96094060001
    HUTCHERSON, John Michael
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector10898310001
    IRVING, John Leslie
    3-5 North Street
    NN7 3JB Rothersthorpe
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    3-5 North Street
    NN7 3JB Rothersthorpe
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector10898330001
    KIPLING, Neil William Stuart
    15 The Downs
    NN9 5YP Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    15 The Downs
    NN9 5YP Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector10898340002
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    PENNA, David Malcolm
    49 Borrowcop Lane
    WS14 9DG Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    49 Borrowcop Lane
    WS14 9DG Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector14573060001
    SHERMAN, Christopher Robert
    Elm Cottage
    City Corner, Hinton Parva
    SN4 0DH Swindon
    Geschäftsführer
    Elm Cottage
    City Corner, Hinton Parva
    SN4 0DH Swindon
    BritishDirector83550360003
    STACEY, Alan Edward
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant50789190001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    BritishFinancial Accountant36622750002

    Hat MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 16. Apr. 2007
    Geliefert am 21. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juli 2004
    Geliefert am 27. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 06. Mai 1997
    Geliefert am 19. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys due or owing from time to time owing to the company under or by virtue of the contract(s) being trade indemnity PLC credit insurance policy number 100117201 together with the benefit of all securities for the same.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and kelexcel limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 24. Feb. 1988
    Geliefert am 29. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge by way of assignment of the timson 2 colour T24 business forms press serial no 18711 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 29. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1988
    Geliefert am 11. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 18. Jan. 1988
    Geliefert am 20. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge by way of assignment of timson two colour T24 business forms press serial no 18710 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of deposit account moneys
    Erstellt am 21. Dez. 1987
    Geliefert am 29. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of the sum of £250,000 or such sum or part thereof as is for the time being standing to the credit of the deposit account with investors in industry group PLC (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 1987
    Geliefert am 29. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0