CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02110320 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RENTCO INTERNATIONAL LIMITED | 25. Sept. 1987 | 25. Sept. 1987 |
| VISORHEAD LIMITED | 13. März 1987 | 13. März 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2015 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2016 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Neil Smith zum Geschäftsführer | 6 Seiten | RP04AP01 | ||||||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum 1 More London Place London SE1 2AF am 25. Apr. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von T I P Europe Limited als Geschäftsführer am 05. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Cakebread als Geschäftsführer am 01. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Neil Campbell Smith als Direktor am 05. Feb. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte | 2 Seiten | SH10 | ||||||||||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||||||||||
Aktienspaltung am 01. Dez. 2014 | 8 Seiten | SH02 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 3 Seiten | MISC | ||||||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 3 Seiten | AUD | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| SMITH, Neil Campbell | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183029170001 | |||||||||
| SWITHENBANK, Joseph Preston | Geschäftsführer | Rue Pillet Will 75009 Paris 2-4 France | France | Us Citizen | 183236480001 | |||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Sekretär | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
| PRICE, Philip Ian | Sekretär | 4 Queenswood Avenue Hutton CM13 1HR Brentwood Essex | British | 75578650002 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Handran | Sekretär | Flat 2 19 Netherhall Gardens NW3 5RL Hampstead London | Australian | 50914130001 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||||||
| TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Sekretär | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
| BEADLE, Paul Laurence | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | United Kingdom | British | 100238650001 | |||||||||
| CAKEBREAD, David | Geschäftsführer | The Quadrant Aztec West BS32 4GQ Bristol 2630 United Kingdom | United Kingdom | British | 183172770001 | |||||||||
| CAMFIELD, Ronald Frederick | Geschäftsführer | Nicholas House 14 Creekview Road CM3 5GU South Woodham Ferrers Essex | British | 81395090001 | ||||||||||
| CHANDLER, Andrew Philip | Geschäftsführer | 66 Baywell Leybourne ME19 5QQ West Malling Kent | British | 53832740001 | ||||||||||
| CITRON, Zachary Joseph | Geschäftsführer | 23 Holders Hill Crescent NW14 1NE London | British | 91783950001 | ||||||||||
| CLARK, Roy Graham | Geschäftsführer | 18 Rosary Gardens SW7 4NT London | British | 65257100001 | ||||||||||
| CLUBB, Ian Mcmaster | Geschäftsführer | Pond House EN5 4PS Hadley Green Hertfordshire | British | 3485960001 | ||||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Geschäftsführer | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | England | British | 61314280001 | |||||||||
| FOSTER, Roy Garvin | Geschäftsführer | 16 Thameside RG9 1BH Henley On Thames Oxfordshire | British | 37099790001 | ||||||||||
| GOODWIN, Eric | Geschäftsführer | Brewers Wood Pondfield Lane Shorne DA12 3LD Gravesend Kent | England | British | 45623310001 | |||||||||
| GOODWIN, Stephen Keith | Geschäftsführer | Tumblewood Cottage 23 Beacon Way SM7 1DZ Banstead Surrey | British | 5343520001 | ||||||||||
| GREEN, Pamela Anne | Geschäftsführer | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
| HOWELL, David | Geschäftsführer | Flat 10 The Isabella Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LR Cobham Surrey | United Kingdom | British | 109591300001 | |||||||||
| IRVING, Ian Richard | Geschäftsführer | 3 Warrington Crescent Little Venice W9 1ED London | England | British | 41228040001 | |||||||||
| MATTHEWS, Terence | Geschäftsführer | Flat 6 Fleming House 20 Danvers Street Chel SW3 London | British | 31419450002 | ||||||||||
| MONTAGUE, Robert Joel | Geschäftsführer | Pusey House SN7 8QB Pusey Oxfordshire | British | 65130630002 | ||||||||||
| OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne | Geschäftsführer | 5 Northfield Wall 59 North Road Highgate N6 London | Australian | 17452320001 | ||||||||||
| PALMER, Christopher Antony | Geschäftsführer | Church Farm East Woodhay RG20 0AL Newbury Berkshire | British | 4764800001 | ||||||||||
| RAINE, Richard Denby | Geschäftsführer | 1 Acris Street SW18 2QT London | British | 50519950001 | ||||||||||
| RIEDIJK, Hans Arie | Geschäftsführer | Trompenburo Straat 10m 1079 TX Amsterdam The Netherlands | Dutch | 57483360001 | ||||||||||
| SMITS, Robert Anthony | Geschäftsführer | Heemraadschapslaan 2 1181 Vb Amstelveen | Dutch | 54592350001 | ||||||||||
| STONE, Richard | Geschäftsführer | 6 Birchways WA4 5DQ Appleton Cheshire | British | 75179060001 | ||||||||||
| THRASHER III, Barrie Holt | Geschäftsführer | Flat 10 25 Queensgate Gardens SW7 5RR London | American | 65472750001 | ||||||||||
| WILSON, Peter Samuel | Geschäftsführer | 5 Thorn Close RG11 4SQ Wokingham Berkshire | British | 59565220001 | ||||||||||
| T I P EUROPE LIMITED | Geschäftsführer | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | 65164760003 |
Hat CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 1996 Geliefert am 30. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an indemnity contained in a sale agreement dated 14TH december 1989 and this deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in and to both of the company's accounts no: 76653161 and 7943407. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 21. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a credit agreement dated 13TH february 1994 as amended on 15TH february 1994 and an agreement dated 15TH march 1994 (as defined) and any other related security documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 18. Mai 1987 Geliefert am 26. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent and trustee for the banks and/ohe overdraft bank as defined in the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 18. Mai 1987 Geliefert am 26. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever agent and turstee for the banks and/or the overdroft bank as defired in the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0