WILLIAM T. EDEN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWILLIAM T. EDEN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02111202
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WILLIAM T. EDEN LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich WILLIAM T. EDEN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hadleigh Park Grindley Lane
    Blythe Bridge
    ST11 9LW Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WILLIAM T. EDEN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WILLIAM T. EDEN LIMITED31. Dez. 198731. Dez. 1987
    ASSETSTEP LIMITED17. März 198717. März 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLIAM T. EDEN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für WILLIAM T. EDEN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 11. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Bryan Stokes am 11. Apr. 2012

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Meyer House No. 5 Bromford Gate Bromford Lane Heartlands Birmingham B24 8DW am 20. Jan. 2012

    1 SeitenAD01

    Kapitalaufstellung am 05. Aug. 2011

    • Kapital: GBP 100
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 04/08/2011
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung und/oder der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2011 bis 31. Dez. 2010

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Glenn Mccardle als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 3 Rippleway Wharf River Road Barking Essex IG11 0DU am 07. Sept. 2010

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Mark Bryan Stokes als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Michael Trippick als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von WILLIAM T. EDEN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STOKES, Mark Bryan
    Grindley Lane
    Blythe Bridge
    ST11 9LW Stoke-On-Trent
    Hadleigh Park
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Grindley Lane
    Blythe Bridge
    ST11 9LW Stoke-On-Trent
    Hadleigh Park
    Staffordshire
    United Kingdom
    153908730001
    STOKES, Mark Bryan
    Oulton Grove
    ST15 8WB Stone
    1
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Oulton Grove
    ST15 8WB Stone
    1
    Staffordshire
    United KingdomBritishChief Operating Officer100570310002
    BETTS, Paul Alex
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    Sekretär
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    British6870750001
    HUNTER, Jacqueline Louise
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    Sekretär
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    BritishFinancial Director147493940002
    TRIPPICK, Michael Wilfred, Dr
    67 The Paddock
    Thorley Park
    CM23 4JW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    67 The Paddock
    Thorley Park
    CM23 4JW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishFinancial Controller105269430002
    BETTS, Paul Alex
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    EnglandBritishCompany Director6870750001
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector1188140001
    EWERS, Andrew William
    76 Queens Drive
    KT5 8PP Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    76 Queens Drive
    KT5 8PP Surbiton
    Surrey
    EnglandBritishDirector57655000001
    FRIEND, Peter Jason
    18 Gypsy Lane
    PL14 4HQ Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    18 Gypsy Lane
    PL14 4HQ Liskeard
    Cornwall
    BritishCompany Director6870760001
    GLOVER, Peter Matthew
    3 Highfield Way
    WD3 2PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Highfield Way
    WD3 2PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishPurchasing Director50953740002
    HUNTER, Jacqueline Louise
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    Geschäftsführer
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    EnglandBritishFinancial Director147493940002
    HUNTER, Jacqueline Louise
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    Geschäftsführer
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    EnglandBritishFinancial Director147493940002
    LAWRENCE, Timothy William
    7 Hanover Square
    W1R 9HE London
    Geschäftsführer
    7 Hanover Square
    W1R 9HE London
    BritishInvestment Director46082110002
    LEVERETT, Gavin Louis
    43 Woodmere Drive
    Old Whittington
    S41 9TE Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    43 Woodmere Drive
    Old Whittington
    S41 9TE Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector121663960001
    LEVY, David Godfrey
    5 Meadowdown
    Weavering
    ME14 5TN Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    5 Meadowdown
    Weavering
    ME14 5TN Maidstone
    Kent
    BritishCompany Director49252480001
    MADDOX, Carolyn Lucy
    40 Belitha Villas
    N1 1PD London
    Geschäftsführer
    40 Belitha Villas
    N1 1PD London
    United KingdomBritishInvestment Director54184630001
    MASSEY, Christopher Robin Neville
    27 Taylor Row
    DA2 7DU Wilmington
    Kent
    Geschäftsführer
    27 Taylor Row
    DA2 7DU Wilmington
    Kent
    BritishCompany Director80724830001
    MCCARDLE, Glenn
    Wirral Cottage
    High Street Wroot
    DN9 2BU Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Wirral Cottage
    High Street Wroot
    DN9 2BU Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector33766950004
    PORT, David Charles
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector58053990001
    SEVIER, Victor William
    Hilcott Twiggs Lane
    Marchwood
    SO40 4UN Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Hilcott Twiggs Lane
    Marchwood
    SO40 4UN Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Director6870790001
    SIMPSON, Charles Frank
    Flowers Mead
    St Ives Road Hemingford Grey
    PE18 9DX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Flowers Mead
    St Ives Road Hemingford Grey
    PE18 9DX Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director6870800002
    TRILK, Nigel Craig, Dr
    Common Farm
    OX25 1TE Blackthorn
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Common Farm
    OX25 1TE Blackthorn
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector147333690001
    TURCK, John Phillip
    12 Courtenay Gardens
    RM14 1DD Upminster
    Essex
    Geschäftsführer
    12 Courtenay Gardens
    RM14 1DD Upminster
    Essex
    BritishCompany Director6870810001
    WEBB, Colin
    26 Sale Drive
    Clothall Common
    SG7 6NS Baldock
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    26 Sale Drive
    Clothall Common
    SG7 6NS Baldock
    Hertfordshire
    BritishDirector57547850002

    Hat WILLIAM T. EDEN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. März 2005
    Geliefert am 26. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Aug. 1999
    Geliefert am 14. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transaktionen
    • 14. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 27. Aug. 1999
    Geliefert am 14. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All actual or contingent obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee on behalf of the secured parties) and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 1996
    Geliefert am 30. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Jan. 1996
    Geliefert am 31. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring agreement dated 7TH march 1994 or any amendment or addition thereto or replacement thereof
    Kurze Angaben
    All the book and other debts due to the company from time to time by way of first fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 4 december 1992 issued by the company
    Erstellt am 12. Jan. 1996
    Geliefert am 22. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all right title and interest of the company in or arising out of s factoring, invoice discounting, or sales ledger financing, agreement dated 3 august 1992 between credit lyonnais commercial finance limited formerly woodchester trade finance limited formerly alexander commercial finance limited and the company and any deeds amending or replacing the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Jan. 1996
    Geliefert am 22. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or lawgra (no.316) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 1995
    Geliefert am 28. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5/7 stem lane industrial estate, new milton, hampshire t/no: HP438428 (part).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1993
    Geliefert am 06. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at moorswater trading estate liskeard cornwall.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1993
    Geliefert am 05. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sawmills lingwood nr.norwich norfolk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1993
    Geliefert am 23. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property to south west of quarry terrace frindsbury kent t/n k 312527.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1993
    Geliefert am 23. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to south west of whitewall way frindsbury kent t/n k 475080.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1993
    Geliefert am 23. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Universal house bilton way dallow road luton beds.t/n bd 106746.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1993
    Geliefert am 23. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at junction of enterprise close and anthonys way frindsbury kent t/n k 583645.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1993
    Geliefert am 23. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 and 7 stem lane industrial estate new milton hampshire t/n hp 213086.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Dez. 1992
    Geliefert am 11. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1992
    Geliefert am 13. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 06. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & buildings lying to the south west of quarry terrace frinsbury rochester kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & buildings on west side of whitewall way frindsbury rochester kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a universal house bilton way dallow road luton bedfordshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the saw mills lingwood nr norwich norfolk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H known as 5 & 7 stem lane industrial estate new milton hampshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land & buildings lying to the south west of whiteham way frindsbury rochester kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 26. Nov. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on south west side of whitewall road strood kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 26. Nov. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land & buildings at moors water trding estate liskeard cornwall.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 26. Nov. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0