WILLIAM T. EDEN LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WILLIAM T. EDEN LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02111202 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILLIAM T. EDEN LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich WILLIAM T. EDEN LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hadleigh Park Grindley Lane Blythe Bridge ST11 9LW Stoke-On-Trent Staffordshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WILLIAM T. EDEN LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
WILLIAM T. EDEN LIMITED | 31. Dez. 1987 | 31. Dez. 1987 |
ASSETSTEP LIMITED | 17. März 1987 | 17. März 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLIAM T. EDEN LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILLIAM T. EDEN LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Bryan Stokes am 11. Apr. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Meyer House No. 5 Bromford Gate Bromford Lane Heartlands Birmingham B24 8DW am 20. Jan. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Aug. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2011 bis 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Glenn Mccardle als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 3 Rippleway Wharf River Road Barking Essex IG11 0DU am 07. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Bryan Stokes als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Trippick als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WILLIAM T. EDEN LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOKES, Mark Bryan | Sekretär | Grindley Lane Blythe Bridge ST11 9LW Stoke-On-Trent Hadleigh Park Staffordshire United Kingdom | 153908730001 | |||||||
STOKES, Mark Bryan | Geschäftsführer | Oulton Grove ST15 8WB Stone 1 Staffordshire | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 100570310002 | ||||
BETTS, Paul Alex | Sekretär | 11 Gleaners Close Weavering ME14 5ST Maidstone Kent | British | 6870750001 | ||||||
HUNTER, Jacqueline Louise | Sekretär | Norwood Cottage Norwood Lane DA13 0YE Meopham Kent | British | Financial Director | 147493940002 | |||||
TRIPPICK, Michael Wilfred, Dr | Sekretär | 67 The Paddock Thorley Park CM23 4JW Bishops Stortford Hertfordshire | British | Financial Controller | 105269430002 | |||||
BETTS, Paul Alex | Geschäftsführer | 11 Gleaners Close Weavering ME14 5ST Maidstone Kent | England | British | Company Director | 6870750001 | ||||
CHAMBERS, Paul Jonathan | Geschäftsführer | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | Director | 1188140001 | |||||
EWERS, Andrew William | Geschäftsführer | 76 Queens Drive KT5 8PP Surbiton Surrey | England | British | Director | 57655000001 | ||||
FRIEND, Peter Jason | Geschäftsführer | 18 Gypsy Lane PL14 4HQ Liskeard Cornwall | British | Company Director | 6870760001 | |||||
GLOVER, Peter Matthew | Geschäftsführer | 3 Highfield Way WD3 2PP Rickmansworth Hertfordshire | British | Purchasing Director | 50953740002 | |||||
HUNTER, Jacqueline Louise | Geschäftsführer | Norwood Cottage Norwood Lane DA13 0YE Meopham Kent | England | British | Financial Director | 147493940002 | ||||
HUNTER, Jacqueline Louise | Geschäftsführer | Norwood Cottage Norwood Lane DA13 0YE Meopham Kent | England | British | Financial Director | 147493940002 | ||||
LAWRENCE, Timothy William | Geschäftsführer | 7 Hanover Square W1R 9HE London | British | Investment Director | 46082110002 | |||||
LEVERETT, Gavin Louis | Geschäftsführer | 43 Woodmere Drive Old Whittington S41 9TE Chesterfield Derbyshire | England | British | Director | 121663960001 | ||||
LEVY, David Godfrey | Geschäftsführer | 5 Meadowdown Weavering ME14 5TN Maidstone Kent | British | Company Director | 49252480001 | |||||
MADDOX, Carolyn Lucy | Geschäftsführer | 40 Belitha Villas N1 1PD London | United Kingdom | British | Investment Director | 54184630001 | ||||
MASSEY, Christopher Robin Neville | Geschäftsführer | 27 Taylor Row DA2 7DU Wilmington Kent | British | Company Director | 80724830001 | |||||
MCCARDLE, Glenn | Geschäftsführer | Wirral Cottage High Street Wroot DN9 2BU Doncaster South Yorkshire | England | British | Director | 33766950004 | ||||
PORT, David Charles | Geschäftsführer | Spellar Park Brandsby YO61 4RN York North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 58053990001 | ||||
SEVIER, Victor William | Geschäftsführer | Hilcott Twiggs Lane Marchwood SO40 4UN Southampton Hampshire | British | Company Director | 6870790001 | |||||
SIMPSON, Charles Frank | Geschäftsführer | Flowers Mead St Ives Road Hemingford Grey PE18 9DX Huntingdon Cambridgeshire | British | Company Director | 6870800002 | |||||
TRILK, Nigel Craig, Dr | Geschäftsführer | Common Farm OX25 1TE Blackthorn Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 147333690001 | ||||
TURCK, John Phillip | Geschäftsführer | 12 Courtenay Gardens RM14 1DD Upminster Essex | British | Company Director | 6870810001 | |||||
WEBB, Colin | Geschäftsführer | 26 Sale Drive Clothall Common SG7 6NS Baldock Hertfordshire | British | Director | 57547850002 |
Hat WILLIAM T. EDEN LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 10. März 2005 Geliefert am 26. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 27. Aug. 1999 Geliefert am 14. Sept. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 27. Aug. 1999 Geliefert am 14. Sept. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All actual or contingent obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee on behalf of the secured parties) and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the secured documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 20. Mai 1996 Geliefert am 30. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Jan. 1996 Geliefert am 31. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring agreement dated 7TH march 1994 or any amendment or addition thereto or replacement thereof | |
Kurze Angaben All the book and other debts due to the company from time to time by way of first fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge supplemental to a debenture dated 4 december 1992 issued by the company | Erstellt am 12. Jan. 1996 Geliefert am 22. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the aforesaid debenture | |
Kurze Angaben Fixed charge over all right title and interest of the company in or arising out of s factoring, invoice discounting, or sales ledger financing, agreement dated 3 august 1992 between credit lyonnais commercial finance limited formerly woodchester trade finance limited formerly alexander commercial finance limited and the company and any deeds amending or replacing the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Jan. 1996 Geliefert am 22. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or lawgra (no.316) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 1995 Geliefert am 28. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5/7 stem lane industrial estate, new milton, hampshire t/no: HP438428 (part). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Apr. 1993 Geliefert am 06. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property at moorswater trading estate liskeard cornwall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Apr. 1993 Geliefert am 05. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sawmills lingwood nr.norwich norfolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1993 Geliefert am 23. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property to south west of quarry terrace frindsbury kent t/n k 312527. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1993 Geliefert am 23. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to south west of whitewall way frindsbury kent t/n k 475080. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1993 Geliefert am 23. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Universal house bilton way dallow road luton beds.t/n bd 106746. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1993 Geliefert am 23. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at junction of enterprise close and anthonys way frindsbury kent t/n k 583645. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1993 Geliefert am 23. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 and 7 stem lane industrial estate new milton hampshire t/n hp 213086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Dez. 1992 Geliefert am 11. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Okt. 1992 Geliefert am 13. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings lying to the south west of quarry terrace frinsbury rochester kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings on west side of whitewall way frindsbury rochester kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a universal house bilton way dallow road luton bedfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the saw mills lingwood nr norwich norfolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H known as 5 & 7 stem lane industrial estate new milton hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land & buildings lying to the south west of whiteham way frindsbury rochester kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on south west side of whitewall road strood kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land & buildings at moors water trding estate liskeard cornwall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0