LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02116902 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
- Herstellung von Brot, Back- und Süßwaren (10710) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PINGATE CATERING LIMITED | 30. März 1987 | 30. März 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Emmett Mcevoy als Direktor am 20. Apr. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Antony David Smith als Geschäftsführer am 20. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Mcdonald als Direktor am 15. Nov. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Suzanne Elizabeth Wise als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 34 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Hinweis auf die Aufhebung von Beschränkungen in der Satzung der Gesellschaft | 2 Seiten | CC02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Suzanne Elizabeth Wise am 01. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Simon Nicholas Wilbraham am 01. Juli 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Michael Peeler am 01. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Antony David Smith als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Peeler als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Nicholas Wilbraham als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 11 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Lawson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Sekretär | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Geschäftsführer | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Geschäftsführer | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Geschäftsführer | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Sekretär | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Sekretär | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Sekretär | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| HOLLOWAY, David John | Sekretär | 25 Edgar Road St Cross SO23 9TN Winchester Hampshire | British | 66183100001 | ||||||
| VANBERGEN, Charles Albert | Sekretär | The White Cottage Childsbridge Lane Seal TN15 0BS Sevenoaks Kent | British | 7384900001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Sekretär | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Sekretär | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Geschäftsführer | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| BARRY, Peter Nigel George | Geschäftsführer | Hall Farmhouse The Street NR16 1EZ Ashwellthorpe Norfolk | England | British | 84886660001 | |||||
| CARTER, Ian Paul | Geschäftsführer | 2 Hedley Gardens Hedge End SO30 2WT Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 79314210001 | |||||
| CHARTERIS, Derek William | Geschäftsführer | Belswains Lane HP3 9PT Hemel Hempstead 111 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 136986090001 | |||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Geschäftsführer | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Geschäftsführer | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| DARA, Alireza | Geschäftsführer | 23 Lynwood Road W5 1JQ London | United Kingdom | British | 22461240001 | |||||
| DAVIES, Lyn Theodore | Geschäftsführer | Cheridene 65 Bowham Avenue CF31 3PA Bridgend Mid Glamorgan | British | 34304310003 | ||||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Geschäftsführer | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| FORREST, Keith Robert Mckenzie | Geschäftsführer | 18 St Andrews Close Moreton On Lugg HR4 8DD Hereford Hereford & Worcester | British | 45838740001 | ||||||
| HARRIS, Gareth Addison | Geschäftsführer | 18 Painters Pightle Hook RG27 9SS Basingstoke Hampshire | England | British | 152131210001 | |||||
| HOLLOWAY, David John | Geschäftsführer | 25 Edgar Road St Cross SO23 9TN Winchester Hampshire | England | British | 66183100001 | |||||
| HOLROYD, Dean | Geschäftsführer | 51 Grove Road SL4 1JD Windsor Berkshire | British | 64875220002 | ||||||
| HYDE, Trevor John | Geschäftsführer | 158 Jerounds CM19 4HH Harlow Essex | British | 71827110001 | ||||||
| JONES, Martin William | Geschäftsführer | Rose Cottage Eathorpe CV33 9DE Leamington Spa Warwickshire | British | 26034610001 | ||||||
| LAWSON, Robert | Geschäftsführer | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| MALPUS, John James | Geschäftsführer | Armitage House Armitage Road WS15 4AZ Armitage Staffordshire | British | 6799180003 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Geschäftsführer | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Geschäftsführer | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Geschäftsführer | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 | ||||||
| PEELER, Andrew Michael | Geschäftsführer | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 87359710001 | |||||
| RELF, Russell Alan | Geschäftsführer | 113 The Chase SS6 8QP Rayleigh Essex | British | 59133030001 | ||||||
| RUDDICK, Ian William | Geschäftsführer | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 98350001 |
Hat LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined) | Erstellt am 28. Feb. 2001 Geliefert am 20. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis. | |
Kurze Angaben All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Erstellt am 11. Sept. 2000 Geliefert am 23. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 18. Nov. 1997 Geliefert am 21. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,620,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 1 x gouet automatic production line comprising 3 x make-up limited, 3 x sogen transfer conveyors, 3 x resting chambers and various other items and goods as listed on the form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 14. Nov. 1997 Geliefert am 18. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,475,118.98 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Various chattels as specified in agreement no. 355-970448-14 dated 14TH november 1997 between the company and the chargee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. März 1997 Geliefert am 20. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £708,265 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben First fixed charge over:- 1 x jackstone manufacturing line, including 3 spiral coolers, 3 spiral freezers with full interconnecting conveyor system, insulation and controls serial no: A193/14. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 07. März 1997 Geliefert am 08. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £311,802 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben 1 x abb power factor corrector serial no.C861407/1-5, 32 x artofex stainless steel equipment, 4 x chilled water fan coil units. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 10. Dez. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,460,285.64 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The items as set out on the schedule attached to form 395 together with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them). Some of the items are one GA18-7.5 Air compressor, 2 40' dry van containers stainless steel, one ADV20-60 and one ADV16-66 condenser and one ADS2-26 and one ADS1-26 dry air cooler. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 15. Juli 1996 Geliefert am 20. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £444,520.70 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Various chattels as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 11. Juli 1996 Geliefert am 11. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395 being:- one new deltamatic DV50 water meter serial number 6497, one new sprint 300 ri mixer serial number 24999, one new generator serial number CO62137/01. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 09. Mai 1996 Geliefert am 11. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £936,432 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Kurze Angaben Various goods comprising 1 x new gouet product line (line number 3). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 02. Okt. 1995 Geliefert am 04. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £518,495.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage | |
Kurze Angaben 1 x microsearch metal detect sys serial number-73734A. 1 x microsearch metal detect sys serial number 73734B. 2 x caseweighers with cintex serial number 2509A.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 01. Aug. 1995 Geliefert am 02. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £312,406 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Various items of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 26. Aug. 1993 Geliefert am 07. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £40486.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All right title & interest in & to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 27. Nov. 1991 Geliefert am 29. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the london superstores limited on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 15. Okt. 1988 Geliefert am 04. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0