LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02119260 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED?
- Nichtlinienflugverkehr für Passagiere (51102) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AIR UK (LEISURE) LIMITED | 07. Juli 1987 | 07. Juli 1987 |
| PRECIS (591) LIMITED | 03. Apr. 1987 | 03. Apr. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Mai 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Joyce Walter am 09. Mai 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christine Margaret Browne am 15. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christine Margaret Browne am 16. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Joyce Walter am 24. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Joyce Walter am 24. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTER, Joyce | Sekretär | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex | British | 76169540002 | ||||||
| BROWNE, Christine Margaret | Geschäftsführer | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 79573340002 | |||||
| WALTER, Joyce | Geschäftsführer | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 76169540003 | |||||
| BROWN, Peter Richard | Sekretär | Branscombe Heather Way Storrington RH20 4DD Pulborough West Sussex | British | 3858240001 | ||||||
| PIPPEN, David | Sekretär | 57 Back Road Writtle CM1 3PD Chelmsford Essex | British | 15688960002 | ||||||
| STARLING, Rebecca Jean Godwin | Sekretär | 11 Rossdale Road Putney SW15 1AD London | British | 45381850004 | ||||||
| ADDISON SMITH, Nigel | Geschäftsführer | 49 Fullerton Road Wandsworth SW18 1BU London | British | 46750900002 | ||||||
| BROWN, Peter Richard | Geschäftsführer | Branscombe Heather Way Storrington RH20 4DD Pulborough West Sussex | British | 3858240001 | ||||||
| BUNN, James Richard | Geschäftsführer | Great Lime Kiln RH13 9JL Southwater 28 West Sussex United Kingdom | British | 98013270002 | ||||||
| CARSON, Stuart | Geschäftsführer | 3 Hawthorn Avenue Sawston CB2 4TE Cambridge Cambridgeshire | British | 60962420002 | ||||||
| DIXON, Jeremy Raylton | Geschäftsführer | Great Dorneys Great Sampford CB10 2RG Saffron Walden Essex | British | 15688990003 | ||||||
| ESSENBERG, Hendricus Arnoldus | Geschäftsführer | The Oaks Forest Hall Road CM24 8TX Stansted Essex | Dutch | 44697530001 | ||||||
| HENRY, David Louis | Geschäftsführer | Hyren House Cawston Road NR10 4LT Reepham Norfolk | England | British | 160301780001 | |||||
| HOWELL, David | Geschäftsführer | Flat 10 The Isabella Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LR Cobham Surrey | United Kingdom | British | 109591300001 | |||||
| JONES, Ian | Geschäftsführer | 2 Church Cottages Ifield Street Ifield RH11 0NN Crawley Sussex | British | 54058850002 | ||||||
| JONES, John | Geschäftsführer | 21 Higher Green KT17 3BB Epsom Surrey | British | 15688970001 | ||||||
| MAY, Iain Richard Campbell | Geschäftsführer | Oak Tree House 17 Curlew Close Tytherington SK10 2SX Macclesfield Cheshire | Gbr | British | 32619030002 | |||||
| OVENDEN, Phillip Sidney | Geschäftsführer | Old Edmeads Five Ash Down TN22 3AP Uckfield East Sussex | British | 70627820001 | ||||||
| PARKER, Christopher John | Geschäftsführer | Lower Burrells East Chiltington BN7 3QU Lewes East Sussex | British | 1998370002 | ||||||
| PAYNE, Harold | Geschäftsführer | Cobwebs 8 Parish Road Stratton Strawless NR10 5LW Norwich Norfolk | British | 15688980001 | ||||||
| SCHMIDT-REPS, Helmuth Werner Jurgen | Geschäftsführer | Flat 2 8 Leopold Road Ealing Common W5 3PD London | German | 51125580001 | ||||||
| SMITH, Kenneth William | Geschäftsführer | 10 Martello Mews BN25 1JT Seaford East Sussex | British | 87819940001 |
Hat LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A manager assignment of insurances | Erstellt am 14. Juli 1998 Geliefert am 31. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other person to the chargee under or pursuant to the management agreement | |
Kurze Angaben All right title interest in and to the insurances and any proceeds of requisition (as defined) of the airbus industrie A321-211. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Manager assignment of securities | Erstellt am 01. Mai 1997 Geliefert am 19. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the assurances being all and any contracts of insurance (inc.reinsurances) to be effected in accordance with the hire purchase agreement dated 1ST may 1997. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft lease agreement | Erstellt am 12. März 1996 Geliefert am 21. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this agreement and any other lease of aircraft or aircraft equipment between the company and the chargee | |
Kurze Angaben Us$ 500,000 to be paid to the lessor in accordance with the provisions of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft lease agreement | Erstellt am 12. März 1996 Geliefert am 21. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this agreement and any other lease of aircraft or aircraft equipment between the company and the chargee | |
Kurze Angaben 500,000 united states dollars to be paid to the lessor in accordance with the provisions of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft lease agreement | Erstellt am 12. März 1996 Geliefert am 20. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aircraft lease agreement; and any other lease of aircraft or aircraft equipment between the lessor and the company (the "other leases") | |
Kurze Angaben 500,000 united states dollars to be paid to the lessor in accordance with the provisions of section 4.4 of the aircraft lease agreement together with all amounts delivered to and held by the lessor as security deposits under the other leases. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of insurance | Erstellt am 17. Jan. 1995 Geliefert am 02. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations of the company to the chargee under an aircraft engine lease dated 1ST april 1992 as novated by a novation agreement dated 22ND december 1994 and modified by modification agreement dated 22ND december 1994 | |
Kurze Angaben The benefit of all the company`s right title and interestin any contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 25. Mai 1993 Geliefert am 09. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and /or unijet group PLC under or pursuant to the terms of a counter indemnity dated 26TH march 1992 and or this charge. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all the parts (as defined) together with any replacement parts and any removed parts which are deemed to be parts and the benefits of any guarantee ,indemnity ,warranty or other security owned or held by the company from time to time in respect thereof.please see doc for further details and compelte list of parts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0