AIM HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AIM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02120855 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AIM HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AIM HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AIM HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AIM LIMITED | 08. Mai 1987 | 08. Mai 1987 |
| EASYCROWN LIMITED | 08. Apr. 1987 | 08. Apr. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AIM HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AIM HOLDINGS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für AIM HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | GAZ2 | |||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Denise Williams als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Ms Vinodka Murria als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kerry Crompton als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Barbara Ann Firth als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Preedy als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul David Gibson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neal Roberts als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neal Roberts als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* am 25. März 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2013 bis 28. Feb. 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Ian Preedy am 15. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Ian Preedy am 16. Aug. 2012 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Richard Ian Preedy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Kerry Jane Crompton am 16. Mai 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Neal Anthony Roberts am 16. Mai 2012 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AIM HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Denise | Sekretär | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176952300001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| BOOTH, Michael David | Sekretär | The Coach House Humber Road HU14 3DW North Ferriby East Yorkshire | British | 88167500001 | ||||||
| CHALLINGER, Sara | Sekretär | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| FAIREY, Michael Craig | Sekretär | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | British | 113317640001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Sekretär | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Sekretär | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| ANDERSON, James Douglas | Geschäftsführer | 4 Stirling Road EH5 3HY Edinburgh | United Kingdom | British | 15707300001 | |||||
| BAGAN, Helen | Geschäftsführer | Flat 4 Spencer Court Spencer Place N1 2AX London | United Kingdom | British | 102014660001 | |||||
| BEARPARK, Richard Mosely | Geschäftsführer | Broadfield 16 Clifford Manor Road GU4 8AG Guildford Surrey | England | British | 121373650001 | |||||
| BOOTH, Michael David | Geschäftsführer | The Coach House Humber Road HU14 3DW North Ferriby East Yorkshire | England | British | 88167500001 | |||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Geschäftsführer | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| DAVIS, John Terence | Geschäftsführer | Greenacres 9 Beverley Road Market Weighton YO4 3JN York North Yorkshire | British | 44635630002 | ||||||
| FAIREY, Michael Craig | Geschäftsführer | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | United Kingdom | British | 113317640001 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Geschäftsführer | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| GARTON, Peter Stuart | Geschäftsführer | 11 Church Street Anlaby HU10 7DG Hull North Humberside | British | 36207450001 | ||||||
| HEWITT, David Dennis | Geschäftsführer | 18 Melton Road North Ferriby HU14 3ET Hull East Yorkshire | United Kingdom | British | 76597830001 | |||||
| HUNT, Peter Charles | Geschäftsführer | 14 The Spinney Swanland HU14 3RD North Ferriby North Humberside | British | 22690310001 | ||||||
| JEFFREY, John Ewan | Geschäftsführer | 6 Kilmany Road Wormit DD6 8PF Newport On Tay Fife | British | 23890370001 | ||||||
| LEUW, Martin Philip | Geschäftsführer | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Geschäftsführer | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| PREEDY, Richard Ian | Geschäftsführer | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| RITCHIE, Alastair James | Geschäftsführer | Mickry Lodge 56 Gamekeepers Road EH4 6LS Edinburgh Lothian | British | 38770080002 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Geschäftsführer | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 12470210004 | |||||
| TAYLOR, Keith Edwin | Geschäftsführer | Church View Ivy Lane Hedon HU12 8BL Hull North Humberside | United Kingdom | British | 16866320001 | |||||
| VELUSSI, Luca | Geschäftsführer | 123 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QP London | United Kingdom | Italian | 113413330003 | |||||
| WILDE, John Henry | Geschäftsführer | 5 Wilkesley Cottages Wilkesley SY13 4BA Whitchurch | British | 36207460002 |
Hat AIM HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Okt. 2007 Geliefert am 15. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 19. Okt. 2006 Geliefert am 02. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Keyman assignation | Erstellt am 04. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy no. 3967240 dated 29TH may 1996 with scottish equitable for the sum of £200,000 on the life of stephen taylor parker together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of life policy | Erstellt am 29. Sept. 1994 Geliefert am 07. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number 3741771 dated 21.3.94 for the sum of £200,000 and all bonuses and benefits and all rights title and interest present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Apr. 1994 Geliefert am 17. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in terms of the £350,000 10% redeemable secured loan stock 1994 of the company created on 21ST december 1993 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of offset. | Erstellt am 20. Juni 1990 Geliefert am 02. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from aim LTD aim commercial systems LTD, aim supplies and print LTD,aim professional systems LTD training services LTD aim retail systems LTD aim communications services LTD aim law data LTD aim finance LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums of the company on any account held by the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Aug. 1987 Geliefert am 27. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AIM HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0