NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED

NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02124685
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED?

    • Zeitungsdruck (18110) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    QUICKDANE LIMITED21. Apr. 198721. Apr. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 23. Sept. 2016

    21 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Juli 2016

    19 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Jan. 2016

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Juli 2015

    24 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL am 08. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Jan. 2015

    22 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Juli 2014

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Juli 2014

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Jan. 2014

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Jan. 2014

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Juli 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. März 2013

    1 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. März 2013

    22 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. März 2013

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Beendigung der Bestellung von Ian Gill als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    32 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unit 3 Kesslers International Business Park Rick Roberts Way Stratford London E15 2NF* am 09. Okt. 2012

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Groom als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EDIGE, Izzet Tahir
    Heathfield Lodge
    Barnet Road
    EN5 3LF Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Heathfield Lodge
    Barnet Road
    EN5 3LF Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish23985090005
    MILLER, Malcolm George
    Dar L Ghomor Olive Street
    St Julians
    Malta
    Geschäftsführer
    Dar L Ghomor Olive Street
    St Julians
    Malta
    MaltaMaltese68218430001
    PEARCE GOULD, Rupert Anthony
    Harston Manor
    Harston
    CB2 5NT Cambridge
    Geschäftsführer
    Harston Manor
    Harston
    CB2 5NT Cambridge
    United KingdomBritish2230820002
    GILL, Ian William
    7 Eaton Close
    SW1W 8JX London
    Sekretär
    7 Eaton Close
    SW1W 8JX London
    British62621640002
    EDIGE, Izzet Tahir
    30
    Horn Beams Drive
    N11 3TB London
    Geschäftsführer
    30
    Horn Beams Drive
    N11 3TB London
    British23985090003
    GROOM, Anthony John
    Rick Roberts Way
    Stratford
    E15 2NP London
    Unit 3 Kesslers International Business Park
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Rick Roberts Way
    Stratford
    E15 2NP London
    Unit 3 Kesslers International Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritish21561860002
    HALL, Alan Richard Finden
    26 West Side Common
    Wimbledon
    SW19 4UQ London
    Geschäftsführer
    26 West Side Common
    Wimbledon
    SW19 4UQ London
    United KingdomBritish25274380001
    HARTLEBURY, Steven Paul
    18 Northgate End
    CM23 2EU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    18 Northgate End
    CM23 2EU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British73813460002
    JOHNSON, Thomas Douglas Glen
    Little Pagehurst
    Staplehurst
    TN12 0JD Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Little Pagehurst
    Staplehurst
    TN12 0JD Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish31405690002
    THULL, Christian J M
    Gleiss Strasse 5
    Hockenheim
    Talhaus
    Germany
    Geschäftsführer
    Gleiss Strasse 5
    Hockenheim
    Talhaus
    Germany
    French31405700001

    Hat NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Chattel mortgage
    Erstellt am 14. Nov. 2008
    Geliefert am 19. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment: cromoman press line (work no. 39-523/1 with serial nos. Set out below). Two folders as follows:. 1 kfn 318459 + folding former 318464, 2 kfn 318450 + folding former 318465. thirteen folders as follows:. 1 printing unit 318552 + 318554 for details of further equipment charged please refer to form 395 by way of first fixed charge all rights, licences, guarantees, rents, contracts, covenants and warranties relating to the equipment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dc Thomson & Company Limited, Miller Distributors Limited, Rupert Pearce Gould & Cambridge Management Consultants Limited
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Account assignment
    Erstellt am 14. Nov. 2008
    Geliefert am 19. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any member of the lloyds tsb group on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assignor assigns with full title guarantee to the security trustee as security trustee for the lenders' all of its rights, title and interest in and to the following (together the assigned assets) the account with the lloyds tsb bank PLC number 0511507 sort code 30-00-02 named re: newsfax international limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and Each Lender (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 13. Nov. 2008
    Geliefert am 20. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any member of the lloyds tsb group on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Full title guarantee to the security trustee as security trustee for the lenders the full benefit of the printing agreement entered into between the assignor and harmsworth printing limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of agreement for lease
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 04. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    An agreement for lease dated 22 december 2006 in relation to the development of and for the grant of a lease of property k/a plot 7 beam reach 5 business park london riverside dagenham. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 16. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The equipment means the two man roland web offset rotary cromoman presses together with all spare parts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • D C Thomson & Company Limited (Secured Party)
    Transaktionen
    • 16. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rent deposit in the sum of £5,700.
    Berechtigte Personen
    • Beckman Property Investments Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 30. Dez. 2005
    Geliefert am 17. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Shares security deed
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 17. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and newsprinters limited or any of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Financial Times Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 04. Juli 2005
    Geliefert am 20. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the company's title rights and interest of whatever nature in and to all the sub hire agreements relating to 2 off thorsted fully automatic inserters type A655-f/w-3 machine no.s:217526 & 217533, 2 of thorsted compensating counter machine nos: 217389 & 217390, stacker type K100 for further details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transaktionen
    • 20. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 16. Feb. 1999
    Geliefert am 18. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1990 thorsted K216 compensating counter stacker with denex lcc-70 laser copy counter inlet conveyor and tow roller delivery tables serial no. A40790471/1, 1989 harris graphics rs-2510 compensating counter stacker with inlet conveyor and delivery conveyor serial no. 251705-10, buhrs zandaam no 3 sleeve wrapping machine serial no 4328, muller martini 338 CS70 compensating counter stacker with 310-14 delivery conveyor serial no. 99.14443/C-467 99.22828.
    Berechtigte Personen
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 22. Okt. 1997
    Geliefert am 24. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 x muller martini 288 compensating stacker - serial no KA99.08362 B 989 1 x thursted K216 compensating counter stacker with denex lcc-70 laser copy counter inlet conveyor and 2 roller delivery tables serial no 9101117. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC, Royscot Leasing Limited, Royscot Industrial Leasing Limited, Royscotcommercial Leasing Limited and Royscot Spa Leasing Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 29. Apr. 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property comprises of the following:- 1 x harris 845 5 unit web offset press with folder & infeed device serial no:155-00B.
    Berechtigte Personen
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 11. Dez. 1996
    Geliefert am 14. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Kurze Angaben
    A deposit of £7,500 together with all interest accruing on such monies.
    Berechtigte Personen
    • Postel Properties Limited
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 09. Sept. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Single debenture
    Erstellt am 23. Okt. 1990
    Geliefert am 08. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 08. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 1988
    Geliefert am 15. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over all and stock in trade. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific Business Finance (Europe) Limited
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 16. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 04. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease dated 12 11 84
    Kurze Angaben
    A deposit of sterling pounds £22,580 maintained at national westminster bank PLC together with all interest accruing thereon (please see doc for details).
    Berechtigte Personen
    • Postel Properties Limited
    Transaktionen
    • 04. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NEWSFAX INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Sept. 2012Beginn der Verwaltung
    23. Sept. 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0