CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02126349 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Meakin als Direktor am 01. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alun Huw Jones als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Edward Oliver Howard als Geschäftsführer am 10. Juni 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Sept. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Sept. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 7 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gavin Edward Oliver Howard als Direktor am 13. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Peter Summers als Geschäftsführer am 23. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEWES, Nicholas Cecil John | Geschäftsführer | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire | England | British | Commercial Director | 64093580002 | ||||
MEAKIN, Richard John | Geschäftsführer | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire | England | British | Finance Director | 282911600001 | ||||
AMIES, Thomas George Timothy | Sekretär | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire | British | Finance Director | 139488480001 | |||||
HOWARD, Judith | Sekretär | The Glebe House 5 Grange Lane Cople MK44 3TT Bedford Bedfordshire | British | 107652540002 | ||||||
AMIES, Thomas George Timothy | Geschäftsführer | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire | United Kingdom | British | Finance Director | 139488480001 | ||||
GRIMES, Thomas Edward | Geschäftsführer | 2 Green Meadow Little Heath EN6 1LL Potters Bar Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 60094770002 | |||||
HOWARD, Brian Edward | Geschäftsführer | The Glebe House Cople MK44 3TT Bedford Bedfordshire | England | British | Director Of Companies | 2384280001 | ||||
HOWARD, Gavin Edward Oliver | Geschäftsführer | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire | England | British | Company Director | 41557430006 | ||||
HOWARD, Judith | Geschäftsführer | The Glebe House 5 Grange Lane Cople MK44 3TT Bedford Bedfordshire | England | British | Director Of Companies | 107652540002 | ||||
JONES, Alun Huw | Geschäftsführer | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire | United Kingdom | British | Finance Director | 79411220001 | ||||
PETITT, James Walter | Geschäftsführer | Woodhaven 8 Ellison Lane Hardwick CB3 7QA Cambridge Cambridgeshire | British | Accountant | 3371040001 | |||||
SUMMERS, Michael Peter | Geschäftsführer | 93 Regent Street Cambridge CB2 1AW Cambridgeshire | England | British | Property Director | 41660410002 | ||||
WOOD, Elliott Arthur John | Geschäftsführer | The Old Granary CB3 7HN Great Eversden Cambridgeshire | British | Property Director | 4217060001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Crescent Limited | 31. Jan. 2017 | Regent Street CB2 1AW Cambridge 93 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CAEC HOWARD (ARKWRIGHT) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 2007 Geliefert am 06. Feb. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Sundance house staniland way werrington peterborough. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Juli 2004 Geliefert am 27. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The werrington centre, werrington, peterborough. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Juli 2004 Geliefert am 16. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation | Erstellt am 24. Juni 2002 Geliefert am 26. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The freehold property known as the werrington centre peterborough t/n CB211766. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. März 1998 Geliefert am 20. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a deed of substitution of even date ("the deed of substitution") | |
Kurze Angaben The company's present and future. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of substitution | Erstellt am 11. März 1998 Geliefert am 20. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,835,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under a mortgage dated 25TH june 1987 | |
Kurze Angaben F/H property k/a the werrington centre, werrington peterborough t/no: CB195290 (part) by way of assignment life policy numbers 1465883 1465885 and 146884. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 25. Juni 1987 Geliefert am 03. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 1,835,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben Arkwright industrial estate, north bedfordshire, bedfordshire. T/no bd 60701 and bd 86265. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0