MCC LEASING (NO.24) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMCC LEASING (NO.24) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02127066
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MCC LEASING (NO.24) LIMITED?

    • Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich MCC LEASING (NO.24) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCC LEASING (NO.24) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MCC LEASING (NO.24) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MCC LEASING (NO.24) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 Seiten4.71

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 1 Churchill Place London E14 5HP zum Barclays Group Archives Dallimore Road Manchester M23 9VA geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 16. Juli 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 03. Juli 2015

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Mohammed Akram als Geschäftsführer am 13. März 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Mark Huckle als Geschäftsführer am 29. Aug. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    27 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 31. März 2014

    1 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Hazel Watson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Gavin John Simpson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Jonathan Mark Huckle als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Duncan Rowberry als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von MCC LEASING (NO.24) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Sekretär
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritishAccountant69140360004
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritishBanker149333050001
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Sekretär
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Sekretär
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Geschäftsführer
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    BritishFinance Director92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    BritishFinance Director47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    BritishChartered Accountant5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    BritishFinancial Controller46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishBanker121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritishFinance Director127470250001
    HUCKLE, Jonathan Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritishBanker163223760001
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Geschäftsführer
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    BritishSenior Manager/Administration25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishChartered Accountant68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritishAccountant108439150001
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    BritishAccountant144700710001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritishAccountant155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishAccountant143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    BritishTreasurer49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritishChartered Accountant49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    BritishCertified Accountant32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrishChartered Accountant122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    BritishAccountant40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Geschäftsführer
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    BritishChartered Accountant58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Geschäftsführer
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Geschäftsführer
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    Hat MCC LEASING (NO.24) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of covenants
    Erstellt am 27. Sept. 2005
    Geliefert am 13. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the ship and all its earnings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nib Capital Bank N.V
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage of a ship
    Erstellt am 27. Sept. 2005
    Geliefert am 13. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty-four sixty-fourth (64/64TH) shares in the british registered ship M.v hatsu shine hull number 1265 official number 910289. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nib Capital Bank N.V
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Owner proceeds account charge
    Erstellt am 21. Juni 2004
    Geliefert am 06. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the sub-charterer, the guarantor or any other person, the company or any other person to the company, the charterer and/or any other member of the charteres group, any other member of the owners group to any one or more of the chartere, the agent, the receivable purchases, strip lc bank, the sub-charterer under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest present and future in respect of the owner proceeds account together with any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relating to the owner proceeds account.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nibn Capital Bank N.V., in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Itself and the Other Beneficiaries
    Transaktionen
    • 06. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Hatsu general assignment
    Erstellt am 21. Juni 2004
    Geliefert am 06. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the sub-charterer, the guarantor or any other person, the company or any other person to the company, the charterer and/or any other member of the charteres group, any other member of the owners group to any one or more of the chartere, the agent, the receivable purchases, strip lc bank, the sub-charterer under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title benefit and interest present and future actual and contingent in to under and in respect of the insurance's and any requisition compensation.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nibn Capital Bank N.V., in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Itself and the Other Beneficiaries
    Transaktionen
    • 06. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 21. Jan. 2003
    Geliefert am 23. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the vessel (M.V."hatsu excel",mhi e-type 6,332 teu container,hull no 1253) with all her earnings thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 21. Jan. 2003
    Geliefert am 23. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the british registered ship M.V."hatsu ethic" with official no 906633 and all her equipment thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An insurance assignment
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 23. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rights, title, benefit and interest in and to the insurances.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A charge over account
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 23. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rights, title, benefit and interest in and to the charged account.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty-four (64/64TH) shares in the british registered ship M.V. "hatsu excel" with official number 905520 and in her equipment and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over account
    Erstellt am 04. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's rights title and interest in and to the charged account by way of first fixed charge including without limitation any and all amounts deposited therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 04. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's rights title and interest in and to the vessel and all her earnings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An insurance assignment
    Erstellt am 04. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's rights title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat MCC LEASING (NO.24) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Juli 2015Beginn der Liquidation
    04. Feb. 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0