WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED

WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02129731
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WOODLEIGH CHRISTIAN NURSING HOME LIMITED02. Sept. 199102. Sept. 1991
    FRINGEHAVEN SERVICES LIMITED08. Mai 198708. Mai 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor am 31. Aug. 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 31. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 110,073
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    18 SeitenAA

    Ernennung von Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Company business 14/05/2010
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Appointed attorney for a director 14/05/2010
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung eines Direktors

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Geschäftsführer
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British84003280001
    MALKIN, David Bainbridge
    16 Haddon Road
    NG19 7BS Mansfield
    Nottinghamshire
    Sekretär
    16 Haddon Road
    NG19 7BS Mansfield
    Nottinghamshire
    British76153840001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158662040001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Geschäftsführer
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    British51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    CURTIS, Peter Anthony
    11 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    11 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandEnglish8753300001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish84003280001
    HILL, Randolph Paul
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15223790003
    HUTSON, Gerald Stanley
    118 Mansfield Road
    Skegby
    NG17 3EF Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    118 Mansfield Road
    Skegby
    NG17 3EF Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    English23307290001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PARKINSON, Geoffrey Thomas
    17 Drummond Drive
    Nuthall
    NG16 1BJ Nottingham
    Geschäftsführer
    17 Drummond Drive
    Nuthall
    NG16 1BJ Nottingham
    British35233280001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    STEINER, Edward Samuel, Dr
    Lane Corbiere
    Cauldwell Drive
    NG18 Mansfield
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Lane Corbiere
    Cauldwell Drive
    NG18 Mansfield
    Nottinghamshire
    English/Swiss23307300001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    British34214100001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    British34214100001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Geschäftsführer
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish80445640001
    WILLIAMS, Hazel
    53 Skegby Lane
    NG19 6QS Mansfield
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    53 Skegby Lane
    NG19 6QS Mansfield
    Nottinghamshire
    British23307320001

    Hat WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 21. Aug. 2008
    Geliefert am 02. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2002
    Geliefert am 03. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Third guarantee and debenture
    Erstellt am 16. Mai 2002
    Geliefert am 30. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The coffee shop 14 broomhill lane mansfield t/n NT174002 and woodleigh christian nursing home norfolk drive mansfield notts t/n NT237294. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Second guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2002
    Geliefert am 11. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee (as security agent for the beneficiaries) (as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Woodleigh, norfolk drive, mansfield, nottinghamshire t/no. NT237294 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Dez. 1988
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £550,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property situate at norfolk drive mansfield in the county of nottingham k/a woodleigh.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 08. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juli 1987
    Geliefert am 16. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Vacation house norfolk drive, mansfield, notts. Tn: nt 63245.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 08. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WOODLEIGH PROPERTY (DORMANT) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0