BURGUNDY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BURGUNDY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02133016 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BURGUNDY LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BURGUNDY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Second Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Flintshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BURGUNDY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WEATHER SHOP LIMITED | 28. Aug. 1987 | 28. Aug. 1987 |
| WARMBRIM LIMITED | 20. Mai 1987 | 20. Mai 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BURGUNDY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 24. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BURGUNDY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. März 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 25. März 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Duncan Andrew Vaughan am 16. Apr. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. März 2015 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Duncan Andrew Vaughan als Sekretär am 12. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Duncan Andrew Vaughan als Direktor am 12. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jayne Katherine Burrell als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jayne Katherine Burrell als Sekretär am 12. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BURGUNDY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN, Duncan Andrew | Sekretär | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | 193426360001 | |||||||
| DHALIWAL, Tarsem Singh | Geschäftsführer | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | United Kingdom | British | 151680990001 | |||||
| VAUGHAN, Duncan Andrew | Geschäftsführer | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | United Kingdom | British | 132416950002 | |||||
| ATTWOOD, Paul Gerard | Sekretär | 12 Holborn Drive L39 3QL Ormskirk Lancashire | British | 72538660001 | ||||||
| BERRY, John Graham | Sekretär | The Poplars Darland Lane Lavister Rossett LL12 0BA Wrexham | British | 10711650001 | ||||||
| BERRY, John Graham | Sekretär | The Poplars Darland Lane Lavister Rossett LL12 0BA Wrexham | British | 10711650001 | ||||||
| BURRELL, Jayne Katherine | Sekretär | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | 159099570001 | |||||||
| CHASE, Suzanne Gabrielle | Sekretär | 68 Linden Gardens Chiswick W4 2EW London | British | 78255980001 | ||||||
| SIGURDSSON, Gunnar | Sekretär | 4 Greenlink Walk Kew Riverside TW9 4AF Richmond Upon Thames London | Icelandic | 114179720001 | ||||||
| BERRY, John Graham | Geschäftsführer | The Poplars Darland Lane Lavister Rossett LL12 0BA Wrexham | Wales | British | 10711650001 | |||||
| BURRELL, Jayne Katherine | Geschäftsführer | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | England | British | 167879930001 | |||||
| CHASE, Suzanne Gabrielle | Geschäftsführer | Linden Gardens Chiswick W4 2EW London 68 United Kingdom | United Kingdom | British | 135246350001 | |||||
| DHALIWAL, Tarsem Singh | Geschäftsführer | 6 Cumbrae Drive Stanney Oaks CH65 9JX Ellesmere Port Cheshire | United Kingdom | British | 112657600001 | |||||
| HARALDSSON, Palmi | Geschäftsführer | Solvallargata 4 FOREIGN 101 Reykjavik Iceland | Iceland | Icelandic | 98086060001 | |||||
| HOSKINS, William John | Geschäftsführer | 3 Homewood Road AL1 4BE St. Albans Hertfordshire | British | 49295070002 | ||||||
| LEIGH, James Bernard | Geschäftsführer | 22 Curzon Park North CH4 8AR Chester Cheshire | British | 76713530001 | ||||||
| MCGREGOR, Keith | Geschäftsführer | 1 The Lodge 10 Coley Avenue RG1 6LQ Reading Berkshire | British | 81212510001 | ||||||
| PRITCHARD, Andrew Simon | Geschäftsführer | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | United Kingdom | British | 42467790003 | |||||
| PRITCHARD, Andrew Simon | Geschäftsführer | Kidnal Grange Kidnal SY14 7DJ Malpas Cheshire | United Kingdom | British | 42467790003 | |||||
| SIGURDSSON, Gunnar | Geschäftsführer | 4 Greenlink Walk Kew Riverside TW9 4AF Richmond Upon Thames London | England | Icelandic | 114179720001 | |||||
| WALKER, Malcolm Conrad, Sir | Geschäftsführer | Broxton Old Hall Broxton CH5 9EF Chester Cheshire | United Kingdom | British, | 161541770001 | |||||
| YATES, Timothy Charles | Geschäftsführer | The Old Pump House Station Road, Desford LE9 9FP Leicester Leicestershire | British | 34910760002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BURGUNDY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Foods Limited | 06. Apr. 2016 | Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NW Flintshire Second Avenue United Kingdom | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat BURGUNDY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 05. Apr. 2012 Geliefert am 13. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 26. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 31. März 2006 Geliefert am 13. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An accession deed | Erstellt am 23. Aug. 2005 Geliefert am 01. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee and or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Jan. 2001 Geliefert am 19. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £353,000 plus interest and charges together with all monies and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee pursuant to a property development grant offer dated 8TH november 1999 | |
Kurze Angaben Property k/a woodwards food service hq building parkway deeside industrial park deeside flintshire - WA92942. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. März 1998 Geliefert am 02. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £340,000 with all other sums due from the company to the chargee under or pursuant to a property development grant offer letter dated 21ST november 1997 | |
Kurze Angaben Beech house,deeside industrial park,deeside,flintshire; wa 500256. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0