COMPELSOURCE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COMPELSOURCE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02133193 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COMPELSOURCE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich COMPELSOURCE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COMPELSOURCE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COMPELSERVE PLC | 16. Aug. 1999 | 16. Aug. 1999 |
| COMPEL PLC | 07. Sept. 1994 | 07. Sept. 1994 |
| COMPEL PLC | 30. Sept. 1987 | 30. Sept. 1987 |
| ISSUESECTOR PUBLIC LIMITED COMPANY | 20. Mai 1987 | 20. Mai 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COMPELSOURCE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für COMPELSOURCE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für COMPELSOURCE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | GAZ2 | |||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 16 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 07. März 2014
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sir Peter Rigby am 14. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Paul Rigby am 14. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COMPELSOURCE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGBY, Peter, Sir | Geschäftsführer | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 15654920006 | |||||
| RIGBY, Steven Paul | Geschäftsführer | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham West Midlands | England | British | 41996820011 | |||||
| GILPIN, Nigel Peter | Sekretär | 172 Widney Lane B91 3LH Solihull West Midlands | British | 42299200003 | ||||||
| GOSSAGE, Neal Trevor | Sekretär | 20 Cawdell Drive LE12 5BW Long Whatton Leicestershire | British | 79300420001 | ||||||
| HOSKING, Jeffrey Francis | Sekretär | 231 Waldegrave Road TW1 4TA Twickenham Middlesex | British | 48462320001 | ||||||
| LEE, Andrew Julian | Sekretär | 5 Crossways Farm London Road Barley SG8 8AQ Royston Hertfordshire | British | 17829780002 | ||||||
| LEE, Andrew Julian | Sekretär | 5 Crossways Farm London Road Barley SG8 8AQ Royston Hertfordshire | British | 17829780002 | ||||||
| MONKS, Terence John | Sekretär | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | 80344460001 | ||||||
| RIGBY, James Peter | Sekretär | The Bell House Old Warwick Road CV35 7BT Rowington Warwickshire | British | 88633720001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Sekretär | Rivendell Little Aston Park Road Little Aston B74 3BZ Sutton Coldfield West Midlands | British | 12470210003 | ||||||
| STOCKLEY, Darren | Sekretär | 20 Waters End Stotfold SG5 4QA Hitchin Hertfordshire | British | 61712020002 | ||||||
| BELL, Colin John Rayner | Geschäftsführer | 1 Gorselands Close KT14 6PU West Byfleet Surrey | British | 49813320001 | ||||||
| BROUGH, Geoffrey | Geschäftsführer | Flat 1 Brondesbury Villas NW6 6AH London | British | 17829810001 | ||||||
| CALLE, David Graeme | Geschäftsführer | 30 Welwyn Hall Gardens AL6 9LF Wewyn Hertfordshire | British | 49813230002 | ||||||
| COX, Anthony | Geschäftsführer | 9 Bloomfield Drive RG12 2JW Bracknell Berkshire | British | 76980810001 | ||||||
| DAVIS, Neville | Geschäftsführer | Manyons Church Lane Barkway SG8 8EJ Royston Hertfordshire | England | British | 17829820001 | |||||
| DEAN, Paul | Geschäftsführer | 2 Abbots Barn Vale Royal Courtyard Whitegate CW8 2BA Northwich Cheshire | British | 49812960002 | ||||||
| EVANS, Robert Ivor | Geschäftsführer | 5 Curleys CM17 0JG Old Harlow Essex | British | 49813400001 | ||||||
| FORBES, Robert Gordon | Geschäftsführer | 7 Woodville Place SG14 3NX Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | 50248110002 | |||||
| HOSKING, Jeffrey Francis | Geschäftsführer | 231 Waldegrave Road TW1 4TA Twickenham Middlesex | British | 48462320001 | ||||||
| HOWLING, Mark Ian | Geschäftsführer | 7 Sharmans Close AL6 0AR Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | 71889290001 | |||||
| JOSS, William Alexander | Geschäftsführer | Cherry Tree Cottage Newbottle OX17 3DD Banbury Oxfordshire | British | 72152610001 | ||||||
| KEMP, John Arthur | Geschäftsführer | 20 Mays Way Potterspury NN12 7PP Towcester Northamptonshire | British | 9281920001 | ||||||
| KEMP, John Arthur | Geschäftsführer | 20 Mays Way Potterspury NN12 7PP Towcester Northamptonshire | British | 9281920001 | ||||||
| KETTERIDGE, Mark Patrick | Geschäftsführer | 64 Compton Avenue BH14 8PY Poole Dorset | British | 60014860001 | ||||||
| LEE, Andrew Julian | Geschäftsführer | 5 Crossways Farm London Road Barley SG8 8AQ Royston Hertfordshire | British | 17829780002 | ||||||
| MILLER, Ross Charles | Geschäftsführer | Primrose Farm Hagg Lane Dunnington YO19 5PE York Yorkshire | England | British | 84739210001 | |||||
| PRICE, Keith Leonard | Geschäftsführer | 39 Sparrow Drive SG2 9FB Stevenage Hertfordshire | British | 70306890002 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Geschäftsführer | Rivendell Little Aston Park Road Little Aston B74 3BZ Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 12470210003 | |||||
| STOCKLEY, Darren | Geschäftsführer | 20 Waters End Stotfold SG5 4QA Hitchin Hertfordshire | British | 61712020002 | ||||||
| TOWELL, Gordon James | Geschäftsführer | Moor Hall Cottage Moor Green Ardeley SG2 7AT Stevenage Hertfordshire | British | 78743090002 | ||||||
| YOUNG, Gary Stuart | Geschäftsführer | 244 Clewer Hill Road SL4 4DY Windsor Berkshire | Canadian | 65016830001 |
Hat COMPELSOURCE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture deed | Erstellt am 08. Jan. 1999 Geliefert am 15. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 03. Aug. 1992 Geliefert am 10. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 03. Aug. 1992 Geliefert am 07. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or compel group PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 20. Aug. 1991 Geliefert am 31. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £73063-28 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All its right, title & interest in & to all sums payable under the insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 29. Sept. 1987 Geliefert am 02. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat COMPELSOURCE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0